THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION
Panoramica
| Nome della società | THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società non registrata |
| Numero di società | SZ000005 |
| Giurisdizione | Scozia |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Indirizzo della sede legale | Standard Life House 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SCOTTISH PROVIDENT INSTITUTION (THE) | 14 apr 1983 | 14 apr 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Ultima dichiarazione di conferma | |
|---|---|
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 12 giu 2025 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nomina di Joanne Edlin come amministratore in data 02 mar 2026 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Sophia Louise Mawlam-Patel come amministratore in data 02 mar 2026 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Pearl Group Secretariat Services Limited il 10 nov 2025 | 3 pagine | CH04 | ||
Modifica dei dettagli di Phoenix Life Limited come persona con controllo significativo il 10 nov 2025 | 5 pagine | PSC05 | ||
Nomina di Paul Shakespeare come amministratore in data 01 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Kirstin Mcdougall come amministratore in data 30 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2024 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2025 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Kerry Elizabeth Mcdermott il 01 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Brid Mary Meaney come amministratore in data 23 ago 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Lindsey Jayne Hayden-Carey come amministratore in data 23 ago 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Kirstin Mcdougall come amministratore in data 01 apr 2024 | 3 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Craig Anthony Baker come amministratore in data 28 apr 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Victoria Anne Reuben come amministratore in data 01 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Kulbinder Kaur Dosanjh come amministratore in data 01 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Peter Kane Mayes come amministratore in data 31 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Modifica dei dettagli di Phoenix Life Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 5 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2023 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||
Nomina di Brid Mary Meaney come amministratore in data 31 dic 2022 | 3 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Jacqueline Dorothy Mary Noakes come amministratore in data 31 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Brindley Place B1 2JB Birmingham 10 United Kingdom |
| 115204320002 | ||||||||||
| BUFFHAM, James Bryan | Amministratore | Wythall Green Way B47 6WG Wythall 1 Birmingham | England | British | 286975590001 | |||||||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Amministratore | Old Bailey EC4M 7AN London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 231199720003 | |||||||||
| EDLIN, Joanne | Amministratore | 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House | England | British | 346063040001 | |||||||||
| HAYDEN-CAREY, Lindsey Jayne | Amministratore | 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House | United Kingdom | British | 326801320001 | |||||||||
| MAWLAM-PATEL, Sophia Louise | Amministratore | 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House | England | British | 346056890001 | |||||||||
| NOAKES, Jacqueline Dorothy Mary | Amministratore | 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House United Kingdom | United Kingdom | Irish | 252091280001 | |||||||||
| REUBEN, Victoria Anne | Amministratore | Old Bailey EC4M 7AN London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 304454960001 | |||||||||
| SHAKESPEARE, Paul | Amministratore | 30 Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House | England | British | 341468000001 | |||||||||
| SUTTON, Kerry Elizabeth | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 259876100002 | |||||||||
| HENDERSON, Gordon | Segretario | Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh Midlothian | British | 344750001 | ||||||||||
| RAMSAY, Caroline | Segretario | 1 Maclean Place Bishopbriggs G64 3BJ Glasgow Lanarkshire | British | 39851670003 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| ARNOTT, Kevin John | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | British | 154697010001 | |||||||||
| ARTHUR, Terence Gordon | Amministratore | 23 St Marys Street PE9 2DG Stamford Lincs | British | 14289720001 | ||||||||||
| BAKER, Craig Anthony | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | British | 208447030001 | |||||||||
| BENNETT, James Douglas Scott | Amministratore | The Well House 3 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | British | 365550003 | ||||||||||
| BRYSON, Norval Mackenzie, Dr | Amministratore | Achmore 1 Hillview Terrace EH12 8RA Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 344790003 | |||||||||
| BURNETT-STUART, Joseph | Amministratore | Ardmeallie House AB54 5RS Huntly Aberdeenshire | British | 1410250001 | ||||||||||
| COLES, Shaun Patrick | Amministratore | Chaplin Walk Great Cornard CO10 0YT Sudbury 4 Suffolk | United Kingdom | British | 95706540001 | |||||||||
| CONNELL, Charles Raymond | Amministratore | Colquhalzie PH3 1LB Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 213150005 | |||||||||
| DENHOLM, James Allan | Amministratore | Greencroft 19 Colquhoun Drive Bearsden G61 4NQ Glasgow | United Kingdom | British | 114870001 | |||||||||
| FAWCETT, Stephen | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | British | 177999500001 | |||||||||
| FODEN, Arthur John | Amministratore | Worleys Hill Upper Culham RG10 8PA Reading Berkshire | British | 15337230003 | ||||||||||
| GEIRINGER, Bruno Marcel David | Amministratore | 83 Westbury Road KT3 5AL New Malden Surrey | United Kingdom | British | 35563990001 | |||||||||
| GRAVES, Kenny | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | England | British | 174685340001 | |||||||||
| GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard | Amministratore | The Rickyard CV23 0JN Easenhall 7 Warwickshire | United Kingdom | British | 130189950001 | |||||||||
| HILLHOUSE, Robert Russell, Sir | Amministratore | 19 Regent Terrace EH7 5BS Edinburgh | British | 61304380001 | ||||||||||
| HUNTLEY, David Charles | Amministratore | Burwood Park Road Hersham KT12 5LJ Walton On Thames 7 Surrey | United Kingdom | British | 133958530001 | |||||||||
| INGLIS, James Craufuird Roger | Amministratore | Inglisfield EH41 4JH Gifford East Lothian | British | 159880001 | ||||||||||
| KASSIMIOTIS, Antonios | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | Australian | 180514160001 | |||||||||
| KIPLING, Michael Robert | Amministratore | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | United Kingdom | British | 89585620001 | |||||||||
| KNOX, Lesley Mary Samuel | Amministratore | 23 Merton Lane N6 6NB London | United Kingdom | British | 165715660002 | |||||||||
| LUSCOMBE, Kerr | Amministratore | 3e Melbourne Court Braidpark Drive, Giffnock G46 6LA Glasgow | Scotland | British | 83541890001 | |||||||||
| MACLEOD, Duncan James | Amministratore | Monkredding House KA13 7QN Kilwinning Ayrshire | Scotland | British | 291270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE PHOENIX LIFE SCP INSTITUTION?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Life Limited | 06 apr 2016 | Brindley Place B1 2JB Birmingham 10 | No | ||||||||
| |||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0