Frank James STANDISH
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | Frank |
| Secondo nome | James |
| Cognome | STANDISH |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 281 |
| Totale | 281 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMC AUSTRALIA | 30 giu 2004 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC AUSTRALIA | 30 giu 2004 | 01 ott 2004 | Sciolta | Amministratore | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC EUROLAND LIMITED | 26 mar 2004 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| READYMIX FINANCE | 05 gen 2004 | 01 ott 2004 | Convertita/Chiusa | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| RMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 01 ott 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC TREASURY LIMITED | 20 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC (SO) LIMITED | 13 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC ATLANTA LIMITED | 11 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC GEORGIA | 02 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC DOLLARS | 02 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC RESERVE NO. 1 | 02 giu 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC TRUSTEES (QUEST) LIMITED | 02 mag 2003 | 01 ott 2004 | Sciolta | Amministratore | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| HBM HUB (TECHNOLOGY) LIMITED | 11 gen 2002 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| HBM HUB LIMITED | 11 gen 2002 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| CEMEX UK SERVICES LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC EXPLORATIONS LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC FINANCE LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC EUROPE LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| STAFF NOMINEES LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Sciolta | Amministratore | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| RMC TRUSTEES (QUEST) LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| CEMEX UK TRADING LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| ROMBUS INSURANCE BROKERS LIMITED | 26 mag 2000 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| GILLINGHAM PORTLAND CEMENT COMPANY LIMITED | 30 apr 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| STAFF NOMINEES LIMITED | 30 apr 2000 | 01 ott 2004 | Sciolta | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| FUEL AND COMBUSTION TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED | 26 apr 2000 | 01 ott 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| CEMEX INVESTMENTS LIMITED | 30 mag 2000 | 29 set 2004 | Attiva | Segretario | R M C House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | British | ||
| CEMEX UK EXECUTIVES' PENSION TRUST LIMITED | 26 mag 2000 | 24 mar 2003 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| CEMEX UK PENSION TRUST LIMITED | 26 mag 2000 | 24 mar 2003 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| CEMEX UK MONEY PURCHASE PENSION TRUST LIMITED | 12 gen 1999 | 20 mar 2003 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| BRUNTINGTHORPE GRAVELS LIMITED | 26 mag 2000 | 12 ott 2001 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| WANLIP GRAVELS LIMITED | 26 mag 2000 | 12 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| RTAL LIMITED | 26 mag 2000 | 23 ott 2000 | Sciolta | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| THE RUGBY GROUP LIMITED | 31 mag 2000 | 04 set 2000 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| ASH RESOURCES LIMITED | 30 apr 2000 | 04 set 2000 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | ||
| RUGBY JOINERY LIMITED | 30 apr 2000 | 04 set 2000 | Attiva | Segretario | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0