LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
Dirigente societario
Nome | LYCIDAS SECRETARIES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 1 |
Inattivo | 49 |
Dimesso | 475 |
Totale | 525 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
REGIUS SCHOOL | 13 giu 1994 | 01 giu 2024 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
HIGHLAND KIN LIMITED | 18 feb 1998 | 21 gen 2020 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
ROTASTAK LIMITED | 03 giu 2004 | 13 dic 2017 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
QB INVESTMENTS LIMITED | 18 feb 2004 | 11 mag 2016 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom |
DHUALT PROPERTY COMPANY LIMITED | 07 dic 1996 | 27 gen 2016 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
MICHAEL LUNN ASSOCIATES LIMITED | 28 mag 1996 | 20 nov 2015 | Sciolta | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom |
HOTEL CONNEXIONS LIMITED | 28 ago 2009 | 28 set 2015 | Sciolta | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
LYCIDAS SECURITIES LIMITED | 22 nov 1996 | 07 set 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
LYCIDAS TRUSTEE COMPANY LIMITED | 30 apr 1989 | 07 set 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
LYCIDAS NOMINEES LIMITED | 30 giu 1988 | 07 set 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
THE ROBERTSON AND MCINTOSH COMPANY LIMITED | 12 mar 1996 | 01 set 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom |
INSURGENT STUDIOS LIMITED | 05 ago 2005 | 31 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
BEAM UK PENSION PLAN TRUSTEE LIMITED | 14 mar 2007 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
JOHN HARVEY & SONS (UK) LIMITED | 07 gen 2007 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
JOHN HARVEY & SONS,LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
D. JOHNSTON & COMPANY (LAPHROAIG) LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
BEAM MANAGEMENT UK LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
HOB REALISATIONS LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
BEAM SUNTORY UK HOLDINGS LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
WM. TEACHER & SONS, LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
THOMAS LOWNDES & CO. LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
COSMI REALISATIONS LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
BEAM GLOBAL DISTRIBUTION (UK) LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
BEAM SUNTORY UK LIMITED | 15 ago 2006 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
DOUGLAS MACKENZIE LIMITED | 17 nov 2003 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom |
YCH (UK) LIMITED | 18 apr 2002 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
BEAM GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED | 19 set 2001 | 28 ago 2015 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
SKYPORTS EUROPE LIMITED | 04 set 2000 | 28 ago 2015 | Sciolta | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
D1553 LIMITED | 04 ott 1996 | 28 ago 2015 | Sciolta | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
ABDIVE OFFSHORE SERVICES LIMITED | 15 lug 2003 | 01 lug 2014 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
BEAR ELLICE LIMITED | 18 feb 1994 | 25 giu 2014 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom |
ICEROBOTICS LTD | 01 feb 2008 | 21 gen 2014 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
ICEROBOTICS HOLDINGS LTD | 22 ago 2007 | 21 gen 2014 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
MULL HALL HOLDINGS LIMITED | 23 dic 1997 | 14 ott 2013 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
MULL HALL CARE LIMITED | 23 dic 1997 | 14 ott 2013 | Attiva | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0