Malcolm David SADLER
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Malcolm |
Secondo nome | David |
Cognome | SADLER |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 21 |
Totale | 21 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREETHS LLP | 01 feb 2013 | 31 mar 2018 | Attiva | Socio di LLP | 80 Mount Street Nottingham NG1 6HH Nottinghamshire | England | ||
HENMANS LIMITED | 30 set 2011 | 31 mar 2018 | Sciolta | Solicitor | Amministratore | 80 Mount Street NG1 6HH Nottingham Cumberland Court England | England | British |
HENMANS FREETH LLP | 17 ago 2006 | 31 mar 2018 | Sciolta | Socio designato di LLP | Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 Oxfordshire | England | ||
OXFORD NOMINEES LIMITED | 09 ott 1998 | 31 mar 2018 | Attiva | Solicitor | Amministratore | John Smith Drive Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 United Kingdom | England | British |
OXFORD NOMINEES LIMITED | 09 ott 1998 | 31 mar 2018 | Attiva | Solicitor | Segretario | John Smith Drive Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 United Kingdom | British | |
CARFAX CORPORATE SERVICES LIMITED | 09 ott 1998 | 31 mar 2018 | Attiva | Solicitor | Segretario | John Smith Drive Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 United Kingdom | British | |
CARFAX CORPORATE SERVICES LIMITED | 09 ott 1998 | 23 mar 2018 | Attiva | Solicitor | Amministratore | John Smith Drive Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 United Kingdom | England | British |
HENMANS FREETH EXECUTOR & TRUSTEE COMPANY LIMITED | 02 ott 2000 | 27 feb 2018 | Attiva | Solicitor | Amministratore | 5000 John Smith Drive Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford Oxfordshire | England | British |
G. COLLINS (FARMS) LIMITED | 06 ott 2009 | 06 dic 2009 | Attiva | Solictor | Amministratore | Oxford Business Park South OX4 2BH Oxford 5000 Oxfordshire United Kingdom | England | British |
HELLESDON SCOTLAND LIMITED | 01 apr 2004 | 21 apr 2005 | Attiva | Solicitor | Amministratore | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | England | British |
EBURY GROUP HOLDINGS LIMITED | 01 apr 2004 | 21 apr 2005 | Attiva | Solicitor | Amministratore | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | England | British |
BLAINSFIELD LIMITED | 01 apr 2004 | 21 apr 2005 | Attiva | Solicitor | Amministratore | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | England | British |
M & J (CHALGROVE) LIMITED | 19 feb 1998 | 27 gen 2003 | Sciolta | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | ||
HARRISON SADLER LIMITED | 21 mag 2001 | Attiva | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | |||
EBURY GROUP HOLDINGS LIMITED | 05 feb 1997 | 15 apr 1998 | Attiva | Solicitor | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | |
GREYWELL PROPERTY LIMITED | 20 feb 1998 | 20 feb 1998 | Attiva | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | ||
THAMES BUSINESS ADVICE CENTRE | 11 lug 1997 | Sciolta | Solicitor | Amministratore | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | England | British | |
TARWOOD PROPERTIES LTD | 21 feb 1996 | 14 mag 1997 | Sciolta | Secretary | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | |
FIFIELD SOFTWARE SYSTEMS LIMITED | 01 nov 1994 | Attiva | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | |||
THE ASPECT COMMUNICATIONS GROUP LIMITED | 21 mag 1992 | 14 set 1993 | Sciolta | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British | ||
VANDERBILT 1992 LIMITED | 09 mar 1993 | 10 mar 1993 | Sciolta | Segretario | 46 Lonsdale Road OX2 7EP Oxford Oxfordshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0