Dean Anthony COOK
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Dean |
| Secondo nome | Anthony |
| Cognome | COOK |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 7 |
| Dimesso | 9 |
| Totale | 16 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPLAN4U LIMITED | 06 giu 2016 | Sciolta | Ceo | Amministratore | CO2 8WR Colchester 20 James Parnell Drive Essex United Kingdom | England | British | |
| BPLANUK LIMITED | 26 apr 2016 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Lodge Lane Langham CO4 5NE Colchester Lodge Park Essex England | England | British | |
| ADORE ABODE LTD | 14 mar 2016 | Sciolta | Director | Amministratore | CO2 8WR Colchester 20 James Parnell Drive Essex England | England | British | |
| I-CAN EUROPE LTD | 24 ago 2009 | Sciolta | Director | Amministratore | 21 Oaklands Park Oakhill Lane IP2 9AL Ipswich Suffolk | United Kingdom | English | |
| COMMERCIAL MESSAGING LTD | 30 mag 2006 | Sciolta | Segretario | 21 Oaklands Park Oakhill Lane IP2 9AL Ipswich Suffolk | English | |||
| COMMERCIAL MESSAGING LTD | 30 mag 2006 | Sciolta | Chairman | Amministratore | 21 Oaklands Park Oakhill Lane IP2 9AL Ipswich Suffolk | United Kingdom | English | |
| CMLMARKETING LTD | 12 lug 1999 | Sciolta | Graphic Designer | Amministratore | CO2 8WR Colchester 20 James Parnell Drive Essex United Kingdom | England | British | |
| GOLDBUGS (PHI LOGO) LTD | 24 nov 2020 | 10 ott 2021 | Attiva | Company Director | Amministratore | 160 City Road EC1V 2NX London Kemp House United Kingdom | England | British |
| I-CAN NANO EUROPE LIMITED | 23 feb 2009 | 04 mag 2016 | Sciolta | Director | Amministratore | 21 Oaklands Park Oakhill Lane IP2 9AL Ipswich Suffolk | United Kingdom | English |
| OAKHILL MANAGEMENT COMPANY (IPSWICH) LIMITED | 29 set 2004 | 26 feb 2016 | Attiva | Managing Director | Amministratore | 21 Oaklands Park Oakhill Lane IP2 9AL Ipswich Suffolk | United Kingdom | English |
| IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD | 20 mar 2015 | 23 nov 2015 | Attiva | Director | Amministratore | Oak Hill Lane IP2 9AL Ipswich 21 United Kingdom | United Kingdom | English |
| SPORTS DRINKS LIMITED | 20 ago 2014 | 23 nov 2015 | Sciolta | Director | Amministratore | 1 Maidstone Road DA14 5RH Sidcup River House Kent England | United Kingdom | English |
| INTERNATIONAL WATER SERVICES PLC | 14 nov 2013 | 30 set 2015 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Oakland Park Oak Hill Lane IP2 9AL Ipswich 21 Suffolk England | United Kingdom | English |
| HEALTHY HYDRATION LIMITED | 01 ott 2014 | 01 apr 2015 | Attiva | Director | Amministratore | 1 Maidstone Road DA14 5RH Sidcup River House Kent England | United Kingdom | English |
| X E SOLUTIONS LTD | 01 ott 2014 | 16 feb 2015 | Sciolta | Managing Director | Amministratore | Western Gardens CM14 4SP Brentwood 7 Essex | United Kingdom | English |
| CHANTRY DRIVE (WORMINGFORD) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 08 mag 2001 | 28 apr 2003 | Attiva | Company Director | Segretario | 2 Chantry Drive CO6 3FD Wormingford Essex | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0