Teresa Carol THOMSON
Persona fisica
| Titolo | Mrs |
|---|---|
| Nome | Teresa |
| Secondo nome | Carol |
| Cognome | THOMSON |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 6 |
| Inattivo | 14 |
| Dimesso | 7 |
| Totale | 27 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERYCO LIMITED | 01 apr 2025 | Attiva | Amministratore | The Haugh Blairgowrie PH10 7ER Perthshire | Scotland | British | ||
| A. PROCTOR INSULATION LIMITED | 01 apr 2025 | Attiva | Amministratore | The Haugh Blairgowrie PH10 7ES Perthshire | Scotland | British | ||
| A. PROCTOR CONSTRUCTION LIMITED | 01 apr 2025 | Attiva | Amministratore | The Haugh Rattray PH10 7ER Blairgowrie Perthshire | Scotland | British | ||
| A.R.M. BUILDINGS LIMITED | 01 apr 2025 | Attiva | Amministratore | Unit 3 Rydal Estate Colton Road WS15 3HF Rugeley Staffordshire | Scotland | British | ||
| A. PROCTOR GROUP LIMITED | 01 apr 2025 | Attiva | Amministratore | The Haugh Blairgowrie PH10 7ER Perthshire | Scotland | British | ||
| GALLOWAY GROUP LTD. | 06 gen 2014 | Attiva | Amministratore | 5 George Square G2 1DY Glasgow G1 | Scotland | British | ||
| GALLOWAY (HOLDINGS) LIMITED | 06 gen 2014 | Sciolta | Amministratore | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place | Scotland | British | ||
| DUCTMATE (EUROPE) LIMITED | 06 gen 2014 | Sciolta | Amministratore | 5 George Square G2 1DY Glasgow G1 | Scotland | British | ||
| KENRICK & JEFFERSON LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| REGIS ENVELOPES LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| K & J ENVELOPES LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| THE GRAB BAG COMPANY LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| EXPRESS ENVELOPES LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| FETTYKIL LIMITED | 11 mag 2007 | Sciolta | Segretario | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | |||
| THE GRAB BAG COMPANY LIMITED | 02 ott 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| K & J ENVELOPES LIMITED | 30 gen 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| REGIS ENVELOPES LIMITED | 30 gen 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| KENRICK & JEFFERSON LIMITED | 30 gen 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| EXPRESS ENVELOPES LIMITED | 30 gen 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| FETTYKIL LIMITED | 30 gen 2006 | Sciolta | Amministratore | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | ||
| SPACE SOLUTIONS (SCOTLAND) LIMITED | 07 mag 2019 | 19 dic 2024 | Attiva | Amministratore | Bishop House 50 Carden Place AB10 1UP Aberdeen | Scotland | British | |
| SMITH ANDERSON PACKAGING LIMITED | 26 mag 2011 | 29 nov 2013 | Attiva | Amministratore | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | |
| SMITH ANDERSON GROUP LIMITED | 01 lug 2009 | 29 nov 2013 | Attiva | Amministratore | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | |
| SMITH ANDERSON GROUP LIMITED | 24 mag 2007 | 29 nov 2013 | Attiva | Segretario | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | ||
| SMITH ANDERSON PACKAGING LIMITED | 11 mag 2007 | 29 nov 2013 | Attiva | Segretario | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | ||
| SMITH ANDERSON ENVELOPES LIMITED | 11 mag 2007 | 29 nov 2013 | Attiva | Segretario | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | ||
| SMITH ANDERSON ENVELOPES LIMITED | 08 giu 2006 | 29 nov 2013 | Attiva | Amministratore | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0