Catherine Denise PRESCOTT
Persona fisica
Titolo | Dr |
---|---|
Nome | Catherine |
Secondo nome | Denise |
Cognome | PRESCOTT |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 3 |
Inattivo | 4 |
Dimesso | 12 |
Totale | 19 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOL LTD | 25 nov 2024 | Attiva | Chair Person | Amministratore | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 England | England | British | |
SKINBIOTHERAPEUTICS PLC | 01 mar 2017 | Attiva | Company Director | Amministratore | Bath Lane Newcastle Helix NE4 5TF Newcastle Upon Tyne The Core England | England | British | |
QUARTET INNOVATION PARTNERS LIMITED | 28 mag 2013 | Sciolta | Director | Amministratore | c/o Business Consultancy Services Station Court, Station Road Great Shelford CB22 5NE Cambridge Windsor House England | England | British | |
UNIVERCELL MARKET LIMITED | 07 gen 2010 | Sciolta | Director | Amministratore | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 United Kingdom | England | British | |
TRACTUS LIFE SCIENCES LTD | 06 mag 2009 | Sciolta | Director | Amministratore | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 Cambridgeshire | England | British | |
TRACTUS LIFE SCIENCES LTD | 06 mag 2009 | Sciolta | Segretario | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 Cambridgeshire | British | |||
BIOLATRIS LIMITED | 30 lug 2007 | Attiva | Consultant | Amministratore | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 Cambridgeshire | England | British | |
VIDEREGEN LIMITED | 17 apr 2014 | 17 mar 2022 | Attiva | Director | Amministratore | Liverpool Science Park 131 Mount Pleasant L3 5TF Liverpool Innovation Centre 1 England | England | British |
ALPHA ADVISORY BOARD LIMITED | 15 lug 2020 | 11 set 2020 | Sciolta | Self Employed | Amministratore | Kimberley Road CB4 1HJ Cambridge 72 England | England | British |
THE INTERNATIONAL MEDICAL EDUCATION TRUST | 12 dic 2012 | 10 dic 2017 | Attiva | Company Director | Amministratore | Northwick Park Institute For Medical Research Tt Block HA1 3UJ Watford Road Harrow Middlesex | England | British |
TILL FINANCIAL LIMITED | 03 giu 2014 | 17 dic 2014 | Sciolta | Director | Amministratore | Floor Titchfield House 69-85 Tabernacle Street EC2A 4RR London 2nd United Kingdom | England | British |
AMURA THERAPEUTICS LIMITED | 31 gen 2006 | 30 giu 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
AMURA LIMITED | 31 gen 2006 | 30 giu 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
AMURA HOLDINGS LIMITED | 31 gen 2006 | 30 giu 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
AMURA TECHNOLOGIES LIMITED | 31 gen 2006 | 30 giu 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
AVLAR LIMITED | 01 ott 2002 | 30 giu 2007 | Attiva | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
CELLCENTRIC LIMITED | 30 ott 2003 | 31 dic 2005 | Attiva | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
YORK PHARMA (R & D) LIMITED | 09 ott 2003 | 07 feb 2005 | Sciolta | Director | Amministratore | Highfield House Church Lane CB3 8AG Madingley Cambridgeshire | British | |
THERASCI LIMITED | 05 lug 2002 | 21 nov 2003 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 6 Eden Street CB1 1EL Cambridge Cambridgeshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0