Dara Marcus CHANGIZI
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Dara |
Secondo nome | Marcus |
Cognome | CHANGIZI |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 8 |
Inattivo | 5 |
Dimesso | 6 |
Totale | 19 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINT FINISHERS & LASER DIES LIMITED | 31 ott 2016 | Attiva | Commercial Property Developer | Amministratore | Cartside Avenue Inchinnan PA4 9RP Renfrew Unit 14 | Scotland | British | |
ACA SCOTLAND LTD | 31 ott 2016 | Attiva | Commercial Property Developer | Amministratore | Cartside Avenue Inchinnan Business Park PA4 9RP Inchinnan Unit 14 | Scotland | British | |
ACA HOLDINGS LIMITED | 31 ott 2016 | Attiva | Commercial Property Developer | Amministratore | Unit 14 Cartside Avenue Inchinnan Business Park PA4 9RP Inchinnan | Scotland | British | |
A.C.A. ASSETS LTD | 31 ott 2016 | Attiva | Commercial Property Developer | Amministratore | Cartside Avenue Inchinnan Business Park PA4 9RP Inchinnan Unit 14 | Scotland | British | |
A.C.A. PRINT FINISHING & PACKAGING SOLUTIONS LTD | 31 ott 2016 | Liquidazione | Commercial Property Developer | Amministratore | Turnberry House G2 2LB 175 West George Street Third Floor Glasgow | Scotland | British | |
ACA GROUP LIMITED | 15 set 2016 | Attiva | Commercial Property Developer | Amministratore | Cartside Avenue Inchinnan Business Park PA4 9RP Inchinnan Unit 14 Renfrew Scotland | Scotland | British | |
CMK INVESTMENTS LIMITED | 17 mag 2016 | Attiva | Property Developer | Amministratore | Cartside Avenue Inchinnan Business Park PA4 9RP Inchinnan 14 | Scotland | British | |
KILLERMONT MOTOR CO LTD | 03 dic 2013 | Attiva | Property Developer | Amministratore | 166 Buchanan Street G1 2LW Glasgow 1/4 United Kingdom | Scotland | British | |
FIRST CHOICE FACTORING LIMITED | 24 set 2013 | Sciolta | Estate Agent | Amministratore | 130-132 High Street G82 1PQ Dumbarton 1st Floor Scotland | Scotland | British | |
KESSINGTON MOTOR SERVICES LTD | 24 mar 2011 | Sciolta | Motor Dealer | Amministratore | Milngavie Road Bearsden G61 2DL Glasgow 79 United Kingdom | Scotland | British | |
KILLERMONT CORPORATE LTD | 18 ott 2007 | Sciolta | Motor Dealer | Amministratore | 10 Heathfield Drive Milngavie G62 8AZ Glasgow | Scotland | British | |
DAKOTA MOTOR GROUP LTD | 11 lug 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | 10 Heathfield Drive Milngavie G62 8AZ Glasgow | Scotland | British | |
DAKOTA MOTOR CO. LTD | 11 lug 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | 10 Heathfield Drive Milngavie G62 8AZ Glasgow | Scotland | British | |
CALEDONIA BUREAU LIMITED | 16 apr 2009 | 28 ott 2020 | Attiva | Estate Agent | Amministratore | High Street G82 1PQ Dumbarton 130 United Kingdom | Scotland | British |
CALEDONIA BUREAU DUMBARTON LIMITED | 09 ago 2012 | 28 ott 2020 | Sciolta | Director | Amministratore | High Street G82 1PQ Dumbarton 130 United Kingdom | Scotland | British |
C & M CAR CARE (SCOTLAND) LTD | 17 mar 2015 | 01 mar 2019 | Sciolta | Proprty Developer | Amministratore | Heathfield Drive Milngavie G62 8AZ Glasgow 10 United Kingdom | Scotland | British |
KESSINGTON LTD | 28 set 2015 | 18 dic 2015 | Sciolta | Proprty Developer | Amministratore | c/o Craig Connelly Lovat Avenue Bearsden G61 3LQ Glasgow 31 | Scotland | British |
COMMERCE CAR COMPANY PAISLEY LTD | 05 gen 2011 | 07 feb 2011 | Sciolta | Director | Amministratore | Lonend PA1 1SU Paisley 26 United Kingdom | Scotland | British |
CALDOW PROPERTY LTD | 08 ott 2008 | 16 dic 2009 | Sciolta | Car Retailer | Amministratore | 10 Heathfield Drive Milngavie G62 8AZ Glasgow | Scotland | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0