John FRANKIEWICZ
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | John |
| Cognome | FRANKIEWICZ |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 24 |
| Totale | 26 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPOR LIMITED | 12 gen 2016 | Attiva | Amministratore | Building A 150-170 Midsummer Boulevard MK9 1FD Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | England | British | ||
| RED ROCK LONDON LIMITED | 30 lug 2015 | Attiva | Amministratore | Building A 150-170 Midsummer Boulevard MK9 1FD Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| EGG HOLDINGS LIMITED | 08 dic 2021 | 31 lug 2022 | Attiva | Amministratore | 15 Stratton Street W1J 8LQ Mayfair Green Park House London United Kingdom | United Kingdom | British | |
| TROY INTERIORS LIMITED | 15 ago 2019 | 31 dic 2021 | Sciolta | Amministratore | Johns Place IP33 1SW Bury St. Edmunds St. Suffolk England | England | British | |
| TROY CENTRAL LIMITED | 01 lug 2017 | 31 dic 2021 | Liquidazione | Amministratore | IP33 1SW Bury St Edmunds St Johns Place Suffolk England | United Kingdom | British | |
| COLLCON PROJECTS LTD | 01 mag 2016 | 04 mag 2020 | Attiva | Amministratore | Riverside Industrial Park Catterall PR3 0HP Preston Lancashire | United Kingdom | British | |
| BRIGGS & FORRESTER LIMITED | 01 lug 2015 | 31 dic 2018 | Attiva | Amministratore | Bembridge House Bembridge Drive Kingsthorpe NN2 6LZ Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | |
| UKGBC LIMITED | 02 feb 2010 | 19 ott 2016 | Attiva | Amministratore | The Building Centre 26 Store Street WC1E 7BT London | United Kingdom | British | |
| UK-GBC TRADING LIMITED | 05 apr 2011 | 22 set 2016 | Attiva | Amministratore | Spirella 2 Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Willmott Dixon Capital Works Herts United Kingdom | United Kingdom | British | |
| CORNERSTONE PROPERTY ASSETS LIMITED | 02 nov 2011 | 31 dic 2014 | Liquidazione | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RE-THINKING COMMUNICATIONS LIMITED | 30 giu 2010 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WPHV LIMITED | 01 feb 2010 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Spirella 2 Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | 01 gen 2010 | 31 dic 2014 | Attiva | Amministratore | Wymington Road NN29 7HP Podington Greys Manor Bedfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON INTERIORS LIMITED | 10 set 2009 | 31 dic 2014 | Attiva | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON LIMITED | 26 mar 2009 | 31 dic 2014 | Attiva | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| INSPACE CORPORATE ASSETS LIMITED | 01 gen 2009 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON SUSTAIN LIMITED | 14 nov 2008 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Spirella 2 Icknield Way SG6 4GY Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| KANVAS INTERIORS LIMITED | 14 nov 2008 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Spirella 2 Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| RE-THINKING SERVICES LIMITED | 29 giu 2006 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON RE-THINKING LIMITED | 29 giu 2006 | 31 dic 2014 | Sciolta | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | 01 mag 1994 | 31 dic 2014 | Attiva | Amministratore | Icknield Way SG6 4GY Letchworth Garden City Spirella 2 Hertfordshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON HOLDINGS LIMITED | 01 gen 2007 | 01 apr 2009 | Attiva | Amministratore | Greys Manor Wymington Road NN29 7HP Podington Northamptonshire | United Kingdom | British | |
| BE LIVING DEVELOPMENTS LIMITED | 01 apr 2005 | 01 nov 2005 | Attiva | Amministratore | Greys Manor Wymington Road NN29 7HP Podington Northamptonshire | United Kingdom | British | |
| BE:HERE HOLDINGS GF LIMITED | 23 gen 2002 | 25 lug 2003 | Sciolta | Amministratore | Greys Manor Wymington Road NN29 7HP Podington Northamptonshire | United Kingdom | British | |
| WILLMOTT DIXON CHILTERNS LIMITED | 20 apr 1999 | Sciolta | Amministratore | Greys Manor Wymington Road NN29 7HP Podington Northamptonshire | United Kingdom | British | ||
| WD INTERIORS LIMITED | 14 mag 1996 | 20 feb 1997 | Sciolta | Amministratore | Greys Manor Wymington Road NN29 7HP Podington Northamptonshire | United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0