David Maurice Benjamin MACMILLAN
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | David |
Secondo nome | Maurice Benjamin |
Cognome | MACMILLAN |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 6 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 24 |
Totale | 31 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGITALLANDSOLUTIONS LTD | 04 feb 2025 | Attiva | Company Director | Amministratore | Cattle Market Street NR1 3DY Norwich Office, 31 Norfolk England | England | English | |
NEXGEN TREE SHELTERS LTD | 01 ott 2024 | Attiva | Company Director | Amministratore | Cheapside Court Sunninghill Road SL5 7RF Ascot 5 England | England | English | |
SIR LEONARD INC LIMITED | 17 mar 2023 | Attiva | Company Director | Amministratore | 6 New Street Square New Fetter Lane EC4A 3AQ London Eighth Floor United Kingdom | England | English | |
THE ROYAL DRAWING SCHOOL | 24 feb 2016 | Attiva | Publisher | Amministratore | 19-22 Charlotte Road London EC2A 3SG | England | English | |
THE HEPATITIS C TRUST | 15 feb 2016 | Attiva | Company Director | Amministratore | Stanley Crescent W11 2NB London 5 England | England | English | |
3PS MEDIA LIMITED | 06 nov 2015 | Attiva | . | Amministratore | Albemarle Street W1S 4BD London 50 Albermarle Street England | England | English | |
ABERNANT LIMITED | 20 set 2004 | Sciolta | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English | |
MARMALADE GAME STUDIO LIMITED | 02 ago 2007 | 23 set 2021 | Attiva | Director | Amministratore | Charlotte Street W1T 1RR London 33 England | England | English |
TYPHOON TRADING LIMITED | 14 apr 1994 | 15 apr 2019 | Attiva | Segretario | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | English | ||
PALLANT HOUSE GALLERY | 14 dic 2007 | 11 dic 2015 | Attiva | Publisher | Amministratore | 9 North Pallant Chichester PO19 1TJ West Sussex | England | English |
ROSECROWN SERVICES LIMITED | 07 lug 2011 | 20 giu 2014 | Sciolta | Publisher | Amministratore | 300 Kensal Road W10 5BE London 119 The Hub | England | English |
CAMILLA LOWTHER LIMITED | 24 nov 1997 | 12 giu 2014 | Attiva | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
MACMILLAN PENSION PLAN LIMITED | 06 ago 2012 | 20 mar 2014 | Attiva | Director | Amministratore | Houndmills RG21 6XS Basingstoke Brunel Road Hampshire | England | English |
SPRINGER NATURE (UK) LIMITED | 25 gen 2000 | 20 mar 2014 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
PAN BOOKSHOPS LIMITED | 15 gen 1998 | 20 mar 2014 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
BED FACTORY HOTELS LIMITED | 16 nov 2004 | 25 giu 2010 | Attiva | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
INFOCANDY GROUP LIMITED | 06 lug 2005 | 07 gen 2008 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
INFOCANDY.COM UK LIMITED | 12 set 2003 | 07 gen 2008 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
THE ADDICTION RECOVERY FOUNDATION LIMITED | 12 giu 2007 | Sciolta | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English | |
WATERROWER (UK) LTD. | 02 mar 1999 | 01 feb 2007 | Attiva | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
ELEPHANT DESIGN LIMITED | 25 mag 2001 | 22 nov 2004 | Attiva | Publisher | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED | 16 gen 1998 | 23 ott 2001 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
BRILLIANT BOOKS LIMITED | 16 mar 2000 | 14 giu 2001 | Sciolta | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
CAMPBELL BOOKS LIMITED | 01 mag 1995 | 06 apr 1999 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
SPRINGER NATURE (UK) LIMITED | 25 set 1995 | 15 gen 1998 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
SPRINGER NATURE LIMITED | 01 lug 1993 | 15 gen 1998 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
PAN BOOKSHOPS LIMITED | 01 lug 1993 | 15 gen 1998 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
MACMILLAN PRESS LIMITED | 15 gen 1998 | Sciolta | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English | |
SIDGWICK & JACKSON,LIMITED | 15 gen 1998 | Sciolta | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English | |
SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED | 25 set 1995 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English | |
PAN MACMILLAN LIMITED | 01 lug 1993 | 19 apr 1995 | Attiva | Publishing Executive | Amministratore | 5 Stanley Crescent W11 2NB London | England | English |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0