PALMERSTON SECRETARIES LIMITED
Dirigente societario
Nome | PALMERSTON SECRETARIES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 31 |
Totale | 31 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
JMC CLEANING LIMITED | 26 giu 2001 | 26 giu 2001 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
LANDLINE (SEVENOAKS) LIMITED | 11 set 2000 | 07 giu 2001 | In amministrazione controllata | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
GOLF COURSE MANAGEMENT (ELEMORE) LIMITED | 02 feb 1998 | 24 nov 2000 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
SUNSCOPE LIMITED | 26 apr 2000 | 22 mag 2000 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
CHIPRO LIMITED | 11 gen 2000 | 09 mar 2000 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
COMPUSOFT GB LIMITED | 24 nov 1999 | 28 feb 2000 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
YELLOWRISE LIMITED | 30 mar 1999 | 30 mar 1999 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
DOCKFORD LIMITED | 12 nov 1998 | 18 feb 1999 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
HOFFLEMAN LIMITED | 28 set 1998 | 28 set 1998 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
BEECHCHASE LIMITED | 25 set 1998 | 25 set 1998 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
OAKDENE HOMES PLC | 03 ago 1998 | 03 ago 1998 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
OAKDENE HOMES (SURREY) LTD | 30 giu 1998 | 30 giu 1998 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
WEAVERING CAPITAL (UK) LIMITED | 20 gen 1998 | 20 gen 1998 | Liquidazione | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
MAGNUMHOLD LIMITED | 20 gen 1998 | 20 gen 1998 | Liquidazione | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
CUSTOMER COMMUNICATIONS LIMITED | 18 lug 1997 | 18 lug 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
JUNE ROSE HOUSE (RESIDENTS) ASSOCIATION LTD | 04 mar 1997 | 08 mag 1997 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
DRAINTECH SOUTH LTD | 08 apr 1997 | 08 apr 1997 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
IN-HOUSE POST-PRODUCTION LTD | 07 mar 1997 | 07 mar 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
STATUS BUILDING SERVICES LTD | 30 ott 1996 | 30 ott 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
EXTREME FACILITIES INTERNATIONAL LIMITED | 25 ott 1996 | 25 ott 1996 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
RIVINGTON CORPORATE PRINT LTD | 27 set 1996 | 27 set 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
KEY BENEFITS LIMITED | 21 giu 1996 | 16 ago 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
MATHEW JACOB CONSULTANCY LTD | 19 gen 1996 | 12 apr 1996 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
WEALD INSURANCE HOLDINGS LIMITED | 29 nov 1995 | 29 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
EUROSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS LIMITED | 28 lug 1995 | 28 lug 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
S J M (FRENCH POLISHERS) LIMITED | 21 lug 1995 | 21 lug 1995 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
BRANFORD LIMITED | 17 mar 1995 | 19 giu 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
YELLO DESIGN & CREATIVE SERVICES LTD | 13 ott 1994 | 05 apr 1995 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
ABLEDENE LIMITED | 18 gen 1995 | 08 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
SPECTRA TRAVEL LIMITED | 31 ott 1994 | 31 ott 1994 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
BURTON & SMITH (UK) LIMITED | 04 lug 1994 | 04 lug 1994 | Attiva | Segretario nominato | Palmerston Business Centre 11 Palmerston Road SM1 4QL Sutton Surrey |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0