Sarah Marie Davenport CHRISTIE
Persona fisica
Titolo | Mrs |
---|---|
Nome | Sarah |
Secondo nome | Marie Davenport |
Cognome | CHRISTIE |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 40 |
Totale | 40 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C & S CHRISTIE LIMITED | 13 mag 1999 | 16 mar 2025 | Sciolta | Segretario | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
C & S CHRISTIE LIMITED | 13 mag 1999 | 16 mar 2025 | Sciolta | Teacher | Amministratore | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | England | British |
PLASTIC IDEAS LIMITED | 13 feb 2004 | 27 ott 2007 | Sciolta | Segretario | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
BAND CONSULTING SERVICES LIMITED | 05 feb 2004 | 21 ott 2007 | Attiva | Segretario | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
PINEAPPLE DINERS LIMITED | 07 giu 2005 | 07 giu 2005 | Sciolta | Segretario | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
HOMEPOWER RETAIL LIMITED | 13 nov 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YELECO 29 LIMITED | 28 set 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (SEP) | 29 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT INVESTMENTS LIMITED | 29 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (DEC) | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (MAR) UNLIMITED | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | |
NVISAGE | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (6) UNLIMITED | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (3) | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (4) | 23 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
METERPLUS LIMITED | 21 lug 1998 | 31 ott 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION SERVICES LIMITED | 22 nov 2000 | 06 giu 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
NORTHERN POWERGRID (YORKSHIRE) PLC | 22 nov 2000 | 24 gen 2001 | Attiva | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YEDL LIMITED | 22 nov 2000 | 24 gen 2001 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ELECTRICITY GROUP SHARE SCHEME TRUSTEES LIMITED | 08 gen 1999 | 16 apr 1999 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
E.ON UK GREEN FUNDING SOLUTIONS LIMITED | 08 set 1998 | 31 dic 1998 | Attiva | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
CBS ENERGY STORAGE ASSETS UK LIMITED | 01 set 1998 | 25 nov 1998 | Attiva | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
BRIGHT SOLUTIONS (LEEDS) LIMITED | 21 ago 1998 | 02 set 1998 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YE GAS LIMITED | 26 giu 1995 | 12 gen 1998 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE WINDPOWER LIMITED | 19 set 1996 | 15 dic 1997 | Attiva | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ENERGY LIMITED | 03 ago 1995 | 15 dic 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
METERPLUS LIMITED | 29 ago 1996 | 08 dic 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YELECO 29 LIMITED | 29 ago 1996 | 28 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT INVESTMENTS LIMITED | 30 giu 1995 | 28 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (MAR) UNLIMITED | 14 giu 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | |
NVISAGE | 14 giu 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (SEP) | 31 mag 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (DEC) | 31 mag 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (6) UNLIMITED | 31 mag 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (3) | 31 mag 1995 | 14 nov 1997 | Sciolta | Segretario | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0