John Esmond BRUCE
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | John |
Secondo nome | Esmond |
Cognome | BRUCE |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 5 |
Inattivo | 3 |
Dimesso | 7 |
Totale | 15 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G WINNARD LIMITED | 26 feb 2025 | Attiva | Director | Amministratore | Mangham Road S62 6EF Rotherham Barbot Hall Industrial Estate South Yorkshire England | England | British | |
VICTORIA MILL MANAGEMENT (BAKEWELL) LIMITED | 30 ott 2024 | Attiva | Company Director | Amministratore | Buxton Road DE45 1DA Bakewell 4 Victoria Mill England | England | British | |
3G TRUCK & TRAILER PARTS LTD | 09 lug 2021 | Attiva | Director | Amministratore | Mangham Road Parkgate S62 6EF Rotherham Barbot Hall Industrial Estate England | England | British | |
3G HOLDCO LIMITED | 11 giu 2021 | Attiva | Director | Amministratore | Sandbeck Way Hellaby S66 8QL Rotherham Hellaby Industrial Estate South Yorkshire United Kingdom | England | British | |
NEWBRIDGE BRAKE LTD. | 13 dic 2013 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 3-5 Newhall Rd Business Park Newhall Road S9 2QD Sheffield Sanderson Works United Kingdom | England | British | |
CINNAMON HOME LIMITED | 01 apr 2004 | Sciolta | Director | Amministratore | Victoria Mill Buxton Road DE45 1DA Bakewell Apartment 4 Derbyshire | England | British | |
JBE LIMITED | 13 mar 2001 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Victoria Mill Buxton Road DE45 1DA Bakewell Apartment 4 Derbyshire | England | British | |
MEI BRAKES LIMITED | 12 mar 1998 | Attiva | Company Director | Amministratore | Victoria Mill Buxton Road DE45 1DA Bakewell Apartment 4 Derbyshire | England | British | |
TVS AUTOMOTIVE EUROPE LIMITED | 10 dic 2001 | 15 giu 2011 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Victoria Mill Buxton Road DE45 1DA Bakewell Apartment 4 Derbyshire | England | British |
PHELAN PRINTERS LIMITED | 08 giu 2006 | 31 ott 2007 | Sciolta | Director | Amministratore | The Dower House Green Lane Cutthorpe S42 7AR Chesterfield Derbyshire | British | |
DUFFIELDS BUSINESS FORMS LIMITED | 18 lug 2005 | 31 ott 2007 | Attiva | Co Director | Amministratore | The Dower House Green Lane Cutthorpe S42 7AR Chesterfield Derbyshire | British | |
MAX EDWARDS LIMITED | 10 gen 2006 | 27 nov 2006 | Sciolta | Segretario | The Dower House Green Lane Cutthorpe S42 7AR Chesterfield Derbyshire | British | ||
SL (PREDECESSORS) | 24 mar 1995 | 13 feb 1998 | Sciolta | Company Director | Amministratore | The Dower House Green Lane Cutthorpe S42 7AR Chesterfield Derbyshire | British | |
KELLETT (UK) LIMITED | 13 feb 1998 | Attiva | Company Director | Amministratore | Horseside Cottage 79 Main Road Holmesfield S18 5WT Sheffield | British | ||
ARGONAUT FREIGHT FORWARDING LIMITED | 18 dic 1995 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Horseside Cottage 79 Main Road Holmesfield S18 5WT Sheffield | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0