SECRETARIES BY DESIGN LIMITED
  • Dati
  • Gran Bretagna
  • Aziende
  • Cerca aziende
  • Sanzioni
  • Cerca sanzioni
  • SECRETARIES BY DESIGN LIMITED

    Dirigente societario

    NomeSECRETARIES BY DESIGN LIMITED
    È un dirigente societario
    Incarichi
    Attivo0
    Inattivo0
    Dimesso185
    Totale185

    Incarichi

    Incarichi assegnati
    Nominato aData di nominaData di dimissioniStato della societàRuoloIndirizzo
    STERNPARK LIMITED19 feb 199319 feb 1994AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    BROADWAY TRAINING LIMITED19 feb 199319 feb 1994AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    M & S LIGHTING CONSULTANTS LIMITED12 feb 199312 feb 1994ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    GAMEBIRD PRODUCTS LIMITED01 apr 199201 ott 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    MENDWEST TRADITIONAL HOMES LIMITED26 apr 199301 ott 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    RHYS DEAN INVESTMENTS LIMITED21 lug 199221 lug 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    J D L FASTENERS LIMITED18 mag 199310 giu 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    RAPID TOOLING COMPANY LIMITED25 mag 199325 mag 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    PHOENIX NEOPRENE SPRAYDECKS LIMITED20 mag 199325 mag 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    ARBOR COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED21 mag 199321 mag 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    3D PLANT AND MACHINERY LIMITED21 mag 199321 mag 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    3D COMPONENTS LIMITED20 mag 199320 mag 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    TGM (HOLDINGS) LIMITED20 mag 199320 mag 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS TUBES UK LIMITED20 mag 199320 mag 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    LEVEL TEXTURE LIMITED18 mag 199318 mag 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    EGGER FORESTRY LIMITED13 mag 199313 mag 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    H F CREATIONS INTERNATIONAL LIMITED19 feb 199306 mag 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    4 LYNDHURST ROAD LIMITED23 apr 199323 apr 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    IBF (METALWORKS) LIMITED20 apr 199320 apr 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    GRANVILLE MANAGEMENT SERVICES LIMITED24 mar 199315 apr 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    HOLLYWOOD REST HOME LIMITED06 apr 199306 apr 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    STEVENSONS BUS SERVICES LIMITED06 apr 199306 apr 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    NELSON HOUSE (TAILORS) LIMITED02 apr 199302 apr 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    EXASOFT LIMITED23 mar 199301 apr 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    MACKWORTH BUSINESS SERVICES LIMITED01 feb 199331 mar 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    CROFT PRINTING LIMITED25 mar 199325 mar 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    TANARD PRODUCTS LIMITED12 feb 199325 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    STRAIGHT LINE DEVELOPMENTS LIMITED24 mar 199324 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    PROSEED EQUIPMENT LIMITED22 mar 199322 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    B C P FABRICATIONS LIMITED18 mar 199318 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    BEAUFORT GARDENS LIMITED17 mar 199317 mar 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    PROTEAN DESIGN LIMITED05 mar 199305 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    CROFT ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED19 gen 199304 mar 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    MAPLEFINE (SKIP HIRE) LIMITED03 mar 199303 mar 1993ScioltaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics
    PRIME ACCOMMODATION LIMITED19 gen 199324 feb 1993AttivaSegretario nominato
    52 Market Street
    Ashby De La Zouch
    LE65 1AN Leics

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0