Bernard Alan RICKINSON
Persona fisica
Titolo | Dr |
---|---|
Nome | Bernard |
Secondo nome | Alan |
Cognome | RICKINSON |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 1 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 18 |
Totale | 20 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVE INTERFACES LIMITED | 01 apr 2019 | Attiva | None | Amministratore | Creighton House 378 Lillie Road SW6 7PH London Studio 2 United Kingdom | England | British | |
INSTITUTE OF PACKAGING (SERVICES) LIMITED(THE) | 29 apr 2008 | Sciolta | Chief Executive | Amministratore | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British | |
MATERIALS UK | 14 set 2010 | 19 giu 2019 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
THE MATERIALS CYCLE AWARDING BODY LIMITED | 23 nov 2017 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 | England | British |
PIABC LIMITED | 01 ott 2016 | 31 dic 2018 | Attiva | Ceo | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
SIGNATURE MATERIALS LIMITED | 03 ott 2012 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS WORLD LTD | 16 ott 2008 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
INSTITUTE OF PACKAGING (THE) | 29 apr 2008 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | c/o Julija Bugajeva Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS UK | 08 mag 2006 | 31 dic 2018 | Attiva | Segretario | Euston Road NW1 3AD London 297 England | British | ||
IOM COMMUNICATIONS LIMITED | 22 apr 1998 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS INSTITUTE SERVICES LIMITED | 29 ott 1997 | 31 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS PROCESSING INSTITUTE | 29 apr 2016 | 21 dic 2018 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | 297 Euston Road NW1 3AQ London The Institute Of Materials, Minerals And Mining United Kingdom | England | British |
CETMAN | 30 gen 2006 | 31 lug 2012 | Sciolta | Chief Executive | Amministratore | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
MATERIALS UK | 08 mag 2006 | 19 dic 2006 | Attiva | Chief Executive | Amministratore | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
BODYCOTE PLC | 01 apr 1998 | 28 mag 2003 | Attiva | Managing Director | Amministratore | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
BODYCOTE H.I.P. LIMITED | 01 apr 1998 | Attiva | Managing Director | Amministratore | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | ||
BODYCOTE PLC | 02 gen 1996 | 31 mar 1997 | Attiva | Director | Amministratore | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE NOMINEES NO. 1 LIMITED | 01 apr 1993 | 31 mar 1997 | Attiva | Company Director | Amministratore | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE METAL TECHNOLOGY LIMITED | 01 gen 1997 | 31 mar 1997 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE HEAT TREATMENTS LIMITED | 01 gen 1997 | Attiva | Managing Director | Amministratore | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0