William Turner MCANENEY
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | William |
| Secondo nome | Turner |
| Cognome | MCANENEY |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 13 |
| Inattivo | 27 |
| Dimesso | 42 |
| Totale | 82 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER 1 KIRKLEE LIMITED | 17 gen 2023 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| EL BIZARRON LIMITED | 17 gen 2023 | Liquidazione | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| JESSIESGW23 LIMITED | 17 gen 2023 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| EL BIZARRON LEASE LIMITED | 17 gen 2023 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| WAVERLY 2023 LIMITED | 17 gen 2023 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| SHAKENMARTINI2023 LIMITED | 17 gen 2023 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow C/O Johnston Carmichael Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | ||
| SUPERLATIVE DINING COLLECTION LTD | 19 ago 2020 | Attiva | Amministratore | G2 2ND Glasgow 227 West George Street United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| EURYBIA LIMITED | 17 dic 2019 | Attiva | Amministratore | 227 West George Street G2 2ND Glasgow Johnston Carmichael Scotland | Scotland | British | ||
| NEWHAVEN 2020 LTD | 15 mag 2018 | Liquidazione | Amministratore | 48 Cleveden Drive G12 0NU Glasgow Flat 1 United Kingdom | Scotland | British | ||
| WENDEL SERVICES LIMITED | 14 giu 2017 | Sciolta | Amministratore | The Coach House 11 Owler Ings Road HD6 1EJ Brighouse 21 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CLEVEDEN 2016 LIMITED | 06 apr 2017 | Sciolta | Amministratore | Suite G3a The Pentagon Centre Washington Street G3 8AZ Glasgow Hastings & Co | Scotland | British | ||
| WHATEVER 2016 LIMITED | 12 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | St. Vincent Street G2 5JF Glasgow 145 Scotland | Scotland | British | ||
| POOSHKA LIMITED | 07 lug 2016 | Sciolta | Amministratore | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British | ||
| HOPE STREET LEASE LIMITED | 19 ott 2015 | Attiva | Amministratore | Hope Street G2 3PT Glasgow 325 Scotland | Scotland | British | ||
| GRAND BABY 1950 LIMITED | 25 mag 2015 | Sciolta | Amministratore | St. Vincent Street G2 5HF Glasgow 5th Floor, 130 | Scotland | British | ||
| GARSCUBE LIMITED | 23 ott 2012 | Sciolta | Amministratore | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British | ||
| AR 2011 LIMITED | 10 ago 2011 | Sciolta | Amministratore | Octavia Terrace PA16 7SR Greenock 49 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | ||
| ST. VINCENT STREET (502) LIMITED | 28 feb 2011 | Sciolta | Amministratore | Octavia Terrace PA16 7SR Greenock 49 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | ||
| INGRAM 33 LIMITED | 30 apr 2010 | Sciolta | Amministratore | Octavia Terrace PA16 7SR Greenock 49 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| DUMBARTON ROAD 143 LIMITED | 30 apr 2010 | Sciolta | Amministratore | Octavia Terrace PA16 7SR Greenock 49 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| GB 1984 LIMITED | 26 apr 2010 | Sciolta | Amministratore | c/o Tpl Admin Limited Robert Drive G51 3HE Glasgow 3 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | ||
| VE 2000 LIMITED | 27 nov 2009 | Sciolta | Amministratore | Octavia Terrace PA16 7SR Greenock 49 Renfrewshire | Scotland | British | ||
| JOHN 2009 LIMITED | 22 apr 2009 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| SQUARE 2009 LIMITED | 23 mar 2009 | Sciolta | Segretario | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | British | |||
| PREGO TRADING LIMITED | 10 dic 2008 | Sciolta | Segretario | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | British | |||
| ST. VINCENT STREET (470) LIMITED | 14 ago 2008 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| RIBS 2006 LTD | 15 feb 2008 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| JOHN STREET TRADING LIMITED | 01 giu 2007 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| CHEESE BAR LEASE LTD. | 23 gen 2007 | Sciolta | Amministratore | The Old Manse PA23 8RX Strone Dunoon | British | |||
| TWISTED WHEEL LEASE LIMITED | 15 nov 2006 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| ELMBANK TRADING LIMITED | 17 mag 2006 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| OTAGO PROPERTIES LIMITED | 24 mar 2006 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| ECCO VINO 2006 PROPERTY LTD. | 17 mar 2006 | Attiva | Amministratore | Cleveden Drive Kelvinside G12 0NU Glasgow 48 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CUBANORTE 2009 LIMITED | 12 gen 2005 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British | ||
| DB 1984 LIMITED | 09 set 2003 | Sciolta | Amministratore | 49 Octavia Terrace PA16 7SR Greenock Renfrewshire | Scotland | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0