Paula Clare HOLLIS
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Paula |
Secondo nome | Clare |
Cognome | HOLLIS |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 39 |
Totale | 39 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. 322 LEICESTER LIMITED | 29 lug 1997 | 08 gen 1999 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
BLL REALISATIONS LIMITED | 19 mar 1997 | 29 ott 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
STRELLA FABRICS LIMITED | 29 lug 1997 | 13 ott 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
WHARF FARM DEVELOPMENTS LIMITED | 28 apr 1997 | 26 giu 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
MEGA FORTRIS (UK) LIMITED | 17 gen 1997 | 22 mag 1997 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
TYNE & WEAR INDUSTRIAL CONSULTANTS LIMITED | 25 mar 1997 | 04 mag 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
BRIAN SMITH EBT LIMITED | 17 gen 1997 | 26 mar 1997 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
ADEPT WORKPLACE SOLUTIONS LIMITED | 05 dic 1996 | 14 mar 1997 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
GRAHAM JOHNSON CELEBRATIONS LIMITED | 23 lug 1996 | 19 nov 1996 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
PAL INTERNATIONAL LIMITED | 31 ott 1996 | 07 nov 1996 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
NO. 278 LEICESTER LIMITED | 23 lug 1996 | 29 ott 1996 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
AMPY HOLDINGS LIMITED | 06 giu 1996 | 08 lug 1996 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
AUSTEN ALLEN LIMITED | 11 mar 1996 | 22 mag 1996 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
HILSTOCK SCP (CLIENT) NOMINEES LIMITED | 02 feb 1996 | 22 apr 1996 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
HILSTOCK PEP (CLIENT) NOMINEES LIMITED | 21 dic 1995 | 22 apr 1996 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
MATTIOLI WOODS LIMITED | 21 dic 1995 | 06 mar 1996 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
22 HATHERLEY GROVE MANAGEMENT LIMITED | 22 giu 1995 | 09 feb 1996 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
HOLMFIELDS LIMITED | 22 giu 1995 | 21 dic 1995 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
LIGHTHOUSE PROPERTY LIMITED | 22 giu 1995 | 29 set 1995 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
MATRAMATIC COMPANY LIMITED | 28 feb 1992 | 07 ago 1995 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
TED NIGHTINGALE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 07 feb 1995 | 20 lug 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
YOUR EMBROIDERY SERVICES LIMITED | 29 nov 1994 | 08 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
GALEN CARE LIMITED | 29 nov 1994 | 13 gen 1995 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
PARLOUR PRODUCTS LIMITED | 29 nov 1994 | 23 dic 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
BPX GROUP LIMITED | 16 mag 1994 | 25 nov 1994 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
HYPERAMA INTERNATIONAL LIMITED | 17 mag 1994 | 26 ott 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
SEDDON DESIGN LIMITED | 11 feb 1994 | 28 apr 1994 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
ADVANCED MICRO LUBRICATION LIMITED | 11 feb 1994 | 12 apr 1994 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
AUTOQUIP OF LEICESTER LIMITED | 19 ott 1993 | 01 nov 1993 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
NO. 205 LEICESTER LIMITED | 11 mag 1993 | 16 set 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
BEACON ENERGY LIMITED | 11 feb 1993 | 06 ago 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
IPL6 LIMITED | 11 feb 1993 | 04 mar 1993 | Sciolta | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
NO. 194 LEICESTER LIMITED | 15 apr 1992 | 05 feb 1993 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
ZIVTEX LIMITED | 16 giu 1992 | 14 gen 1993 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British | ||
RATCLIFFE ENTERPRISES LIMITED | 15 apr 1992 | 01 lug 1992 | Attiva | Segretario nominato | 44 Colchester Road LE5 2DF Leicester Leicestershire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0