John Edward SPANSWICK
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | John |
Secondo nome | Edward |
Cognome | SPANSWICK |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 17 |
Totale | 17 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPLE'S PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED | 02 mar 2011 | 02 ago 2017 | Attiva | Construction | Amministratore | Manor Royal Crawley RH10 9QP West Sussex | England | British |
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING BENEFITS SCHEME TRUSTEE LIMITED | 02 mar 2011 | 02 ago 2017 | Attiva | Construction | Amministratore | Manor Royal Crawley RH10 9QP West Sussex | England | British |
BRIGHTON COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOLS LIMITED | 12 ott 2012 | 08 lug 2014 | Attiva | Chairman | Amministratore | Eastern Road BN2 0AL Brighton Brighton College East Sussex | England | British |
BRIGHTON COLLEGE | 03 mar 2012 | 08 lug 2014 | Attiva | Chairman | Amministratore | Eastern Road BN2 0AL Brighton Brighton College East Sussex United Kingdom | England | British |
B & C E INSURANCE LIMITED | 11 mag 2011 | 20 mag 2014 | Attiva | Construction | Amministratore | Manor Royal Crawley RH10 9QP West Sussex | England | British |
PEOPLE'S ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | 02 mar 2011 | 20 mag 2014 | Attiva | Construction | Amministratore | Manor Royal Crawley RH10 9QP West Sussex | England | British |
ENJAYS LIMITED | 18 apr 2011 | 05 nov 2013 | Sciolta | Retired | Amministratore | Unit 4 Lockwood Park Parkside Lane LS11 5UX Leeds Pancake House West Yorkshire England | United Kingdom | British |
DYNAMINC LIMITED | 26 ott 2011 | 25 giu 2012 | Attiva | Director | Amministratore | Forest Crescent KT21 1JU Ashtead 9 Surrey United Kingdom | England | British |
DYNAMIC GREENWICH LTD | 08 dic 2011 | 25 giu 2012 | Sciolta | None | Amministratore | Mitre Passage Greenwich SE10 0ER London 6 | England | British |
DYNAMIC TOWER 2012 LIMITED | 20 ott 2011 | 25 giu 2012 | Sciolta | Director | Amministratore | Forest Crescent KT21 1JU Ashtead 9 Surrey United Kingdom | England | British |
BE ONSITE | 11 ott 2007 | 11 mar 2011 | Attiva | Director | Amministratore | 142 Northolt Road Harrow HA2 0EE Middlesex | England | British |
LENDLEASE CONSTRUCTION HOLDINGS (EUROPE) LIMITED | 16 mag 2001 | 11 mar 2011 | Attiva | Company Director | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | England | British |
LENDLEASE CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | 11 mar 2011 | Attiva | Company Director | Amministratore | 142 Northolt Road Harrow HA2 0EE Middlesex | England | British | |
LEND LEASE CONSTRUCTION TANVEC GROUP LIMITED | 02 ago 1999 | 11 mar 2011 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Northolt Road HA2 0EE Harrow 142 Middlesex | England | British |
MAJOR CONTRACTORS GROUP LIMITED | 27 giu 2005 | 25 mag 2009 | Sciolta | Director | Amministratore | 9 Forest Crescent KT21 1JU Ashtead Surrey | England | British |
BOVIS URBAN RENEWAL LIMITED | 01 ott 1997 | Sciolta | Director | Amministratore | 9 Forest Crescent KT21 1JU Ashtead Surrey | England | British | |
LENDLEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED | 21 gen 1994 | 18 giu 1997 | Attiva | Director | Amministratore | 9 Forest Crescent KT21 1JU Ashtead Surrey | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0