William Watt GRANT
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | William |
| Secondo nome | Watt |
| Cognome | GRANT |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 16 |
| Inattivo | 11 |
| Dimesso | 13 |
| Totale | 40 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUM DEVELOPMENTS LIMITED | 19 feb 2019 | Sciolta | Amministratore | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | ||
| VENTUM PROPERTIES LIMITED | 30 gen 2019 | Sciolta | Amministratore | Milverton ML6 6EA Airdrie Milverton United Kingdom | Scotland | British | ||
| VENTUM PROPERTIES LIMITED | 30 gen 2019 | Sciolta | Segretario | Milverton ML6 6EA Airdrie Milverton United Kingdom | British | |||
| VENTUM GROUP LIMITED | 05 mar 2018 | Sciolta | Amministratore | Thorncliffe Hall Annex Thorncliffe Park S35 2PH Sheffield Hall 3b England | Scotland | British | ||
| NBA FORESTRY LIMITED | 16 nov 2016 | Attiva | Amministratore | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 United Kingdom | Scotland | British | ||
| VENTUM LIMITED | 06 apr 2016 | Sciolta | Amministratore | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | ||
| BOARDMAN DECORATORS LIMITED | 23 feb 2016 | Sciolta | Amministratore | Thorncliffe Hall Annex Thorncliffe Park S35 2PH Sheefield Hall 3b United Kingdom | Scotland | British | ||
| UK RENEWABLES LIMITED | 16 dic 2015 | Attiva | Segretario | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 Scotland | British | |||
| UK RENEWABLES LIMITED | 16 dic 2015 | Attiva | Amministratore | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 Scotland | Scotland | British | ||
| EH PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 31 lug 2015 | Sciolta | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | ||
| BM LAND LIMITED | 07 apr 2015 | Attiva | Amministratore | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | ||
| BM LAND LIMITED | 07 apr 2015 | Attiva | Segretario | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | British | |||
| EH PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | 04 ago 2014 | Sciolta | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | ||
| CODA OCTOPUS (UK) HOLDINGS LIMITED | 31 ott 2007 | Sciolta | Segretario | Milverton Springwells Avenue ML6 6EA Airdrie Lanarkshire | British | |||
| LAKEMANSE LIMITED | 15 apr 2005 | Attiva | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | British | |||
| LAKEMANSE LIMITED | 15 apr 2005 | Attiva | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | ||
| DARNRIGG LTD. | 07 mag 2001 | Attiva | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | British | |||
| ACREGLEN LIMITED | 04 dic 2000 | Attiva | Segretario | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 United Kingdom | British | |||
| ACREGLEN LIMITED | 04 dic 2000 | Attiva | Amministratore | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 Scotland | Scotland | British | ||
| DARNRIGG LTD. | 03 mag 2000 | Attiva | Amministratore | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 United Kingdom | Scotland | British | ||
| FENCEHILLHEAD LIMITED | 06 nov 1998 | Attiva | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | ||
| FENCEHILLHEAD LIMITED | 06 nov 1998 | Attiva | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | British | |||
| BM LANDHOLDINGS LIMITED | 04 feb 1998 | Sciolta | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | British | |||
| CHARTMOUNT MINERALS LIMITED | 16 dic 1997 | Attiva | Segretario | South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh 5 | British | |||
| CHARTMOUNT MINERALS LIMITED | 16 dic 1997 | Attiva | Amministratore | 24238 EH7 9HR Edinburgh Sc181116 - Companies House Default Address | Scotland | British | ||
| CHARTMOUNT LANDHOLDINGS LIMITED | 26 nov 1997 | Attiva | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | ||
| BM LANDHOLDINGS LIMITED | 26 nov 1997 | Sciolta | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CHARTMOUNT LANDHOLDINGS LIMITED | 15 mar 1993 | 02 gen 2019 | Attiva | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | British | ||
| FM1 GROUP HOLDINGS LIMITED | 23 feb 2016 | 24 gen 2018 | Sciolta | Amministratore | Thorncliffe Hall Annex Thorncliffe Park S35 2PH Sheffield Hall 3b United Kingdom | Scotland | British | |
| FIRST MAINTENANCE (YORKSHIRE) LTD | 23 feb 2016 | 17 gen 2018 | Sciolta | Amministratore | Thorncliffe Hall Annex Thorncliffe Park S35 2PH Sheffield Hall 3b United Kingdom | Scotland | British | |
| CODA OCTOPUS R & D LTD. | 31 ott 2007 | 09 dic 2015 | Attiva | Segretario | 2nd Floor 1 Breadalbane Street EH6 5JR Edinburgh Anderson House | British | ||
| UK RENEWABLES LIMITED | 01 giu 2006 | 01 gen 2014 | Attiva | Segretario | Milverton Springwells Avenue ML6 6EA Airdrie Lanarkshire | British | ||
| UK RENEWABLES LIMITED | 01 giu 2006 | 01 gen 2014 | Attiva | Amministratore | Milverton Springwells Avenue ML6 6EA Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | |
| CODA OCTOPUS R & D LTD. | 31 ott 2008 | 01 giu 2013 | Attiva | Amministratore | Milverton Springwells Avenue ML6 6EA Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | |
| DRAGON DESIGN LIMITED | 01 lug 2011 | 20 set 2011 | Sciolta | Amministratore | Springwells Avenue ML6 6EA Airdrie Milverton Lanarkshire Scotland | Scotland | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0