Niall Fraser MELLORS
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Niall |
Secondo nome | Fraser |
Cognome | MELLORS |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 2 |
Dimesso | 13 |
Totale | 15 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT BUSINESS COACHING LIMITED | 15 feb 2012 | Sciolta | Director | Amministratore | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AL Eastleigh 132a Hampshire England | England | British | |
NMBS LIMITED | 29 nov 2005 | Sciolta | Chartered Accountant | Amministratore | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AL Eastleigh 130 Hampshire England | United Kingdom | British | |
IMPACT BUSINESS COACHING LIMITED | 19 giu 2007 | 31 gen 2012 | Sciolta | Chartered Accountant | Segretario | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AL Eastleigh 130 Hampshire England | British | |
IMPACT BUSINESS COACHING LIMITED | 19 giu 2007 | 31 gen 2012 | Sciolta | Chartered Accountant | Amministratore | Bournemouth Road Chandler's Ford SO53 3AL Eastleigh 130 Hampshire England | United Kingdom | British |
HAMWORTHY HEATING LIMITED | 30 giu 2003 | 31 lug 2005 | Attiva | Finance Director | Segretario | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | British | |
HAMWORTHY HEATING LIMITED | 30 giu 2003 | 31 lug 2005 | Attiva | Finance Director | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
HEATING PRODUCTS LIMITED | 30 giu 2003 | 31 lug 2005 | Attiva | Finance Director | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
HEATING PRODUCTS LIMITED | 30 giu 2003 | 31 lug 2005 | Attiva | Finance Director | Segretario | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | British | |
GUILBERT UK PENSION TRUSTEES LIMITED | 27 apr 1999 | 31 mag 2001 | Attiva | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
OFFICE 1 LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Sciolta | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
NICEDAY DISTRIBUTION CENTRE LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Sciolta | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
GUILBERT OFREX LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Sciolta | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
OFFICE 1 (1995) LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Sciolta | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
DS REMCO UK LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Liquidazione | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
DS REMCO G UK LIMITED | 18 mar 1999 | 31 mag 2001 | Liquidazione | Company Executive | Amministratore | 20 Yewberry Way SO53 4PE Chandlers Ford Hampshire | Gbr | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0