William Henry Mark ROBSON
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | William |
| Secondo nome | Henry Mark |
| Cognome | ROBSON |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 6 |
| Inattivo | 7 |
| Dimesso | 246 |
| Totale | 259 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT STEEL TOPCO LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub United Kingdom | England | British | ||
| PROJECT STEEL MIDCO 2 LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub United Kingdom | England | British | ||
| PROJECT STEEL BIDCO LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub England | England | British | ||
| UTILITY BIDDER HOLDINGS LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub England | England | British | ||
| UTILITY BIDDER LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub England | England | British | ||
| PROJECT STEEL MIDCO 1 LIMITED | 24 lug 2019 | Attiva | Amministratore | Bangrave Road South NN17 1NN Corby Corby Innovation Hub United Kingdom | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 11) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 12) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 9) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 8) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 10) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 7) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| THORNTONS PROPERTY (NO. 6) LIMITED | 04 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Thornton Park Somercotes DE55 4XJ Derby | England | British | ||
| TURNSTONE EQUITYCO 1 LIMITED | 01 ago 2017 | 31 dic 2017 | Attiva | Amministratore | Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House Europa Trading Estate United Kingdom | England | British | |
| DENTURE EXCELLENCE (FRANCHISING) LIMITED | 07 feb 2017 | 31 lug 2017 | Sciolta | Amministratore | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House United Kingdom | England | British | |
| PIERCE & GEDDES LIMITED | 18 ott 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | England | British | |
| MAIDWELL DENTAL PRACTICE LIMITED | 13 mag 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House Europa Trading Estate | England | British | |
| N S DENTAL LTD | 26 apr 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Johnston Street PA1 1XQ Paisley 1 Renfrewshire | England | British | |
| DOLBY MEDICAL EBT TRUSTEE LIMITED | 31 mar 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Johnston Street PA1 1XQ Paisley 1 Renfrewshire Scotland | England | British | |
| HAYLE DENTAL PRACTICE LIMITED | 31 mar 2016 | 31 lug 2017 | Sciolta | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House United Kingdom | England | British | |
| DOLBY MEDICAL LIMITED | 31 mar 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Johnston Street PA1 1XQ Paisley 1 Renfrewshire Scotland | England | British | |
| PDS DENTAL LABORATORY LEEDS LIMITED | 18 mar 2016 | 31 lug 2017 | Sciolta | Amministratore | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | England | British | |
| A-LIST DENTISTRY LIMITED | 18 mar 2016 | 31 lug 2017 | Sciolta | Amministratore | Europa Trading Estate, Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House England | England | British | |
| HALLDENT LIMITED | 27 gen 2016 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester United Kingdom | England | British | |
| CHAPEL ROAD ORTHODONTICS LIMITED | 18 dic 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House United Kingdom | England | British | |
| STALBRIDGE DENTAL PRACTICE LIMITED | 11 dic 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House | England | British | |
| DM AND LJ JORDAN LIMITED | 29 set 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester | England | British | |
| PREMIER DENTAL LIMITED | 29 set 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House Europa Trading Estate | England | British | |
| D AND L JORDAN LIMITED | 29 set 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester | England | British | |
| D M JORDAN LIMITED | 29 set 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester | England | British | |
| MED-FX LTD | 28 ago 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road Kearsley M26 1GG Manchester Europa House United Kingdom | England | British | |
| AESTHETIC DENTAL CARE LIMITED | 27 lug 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | Europa Trading Estate Stoneclough Road M26 1GG Kearsley Europa House Manchester | England | British | |
| ORTHODONTIC SERVICES LIMITED | 17 lug 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | 6th Floor 42-46 Fountain Street BT1 5EF Belfast A&L Goodboy Solicitors Northern Ireland | England | British | |
| STUNNING SMILES LTD | 29 giu 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | c/o A&L Goodbody Solicitors 6th Floor 42-46 Fountain Street BT1 5EF Belfast A&L Goodbody Solicitor Northern Ireland | England | British | |
| DENTAL AESTHETICS LTD | 29 giu 2015 | 31 lug 2017 | Attiva | Amministratore | c/o A&L Goodbody Solicitors 6th Floor 42-46 Fountain Street BT1 5EF Belfast A&L Goodbody Solicitor Northern Ireland | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0