David TIDMARSH
Persona fisica
| Titolo | |
|---|---|
| Nome | David |
| Cognome | TIDMARSH |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 37 |
| Totale | 37 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CONSTRUCTION MATERIALS LIMITED | 03 giu 2011 | 21 dic 2016 | Sciolta | Amministratore | Vestry Road TN14 5EL Sevenoaks Conway House Kent | United Kingdom | British | |
| UNITED CONCRETE LIMITED | 30 set 2008 | 21 dic 2016 | Sciolta | Amministratore | Vestry Road TN14 5EL Sevenoaks Conway House Kent | United Kingdom | British | |
| UNITED ASPHALT CONTRACTING LIMITED | 30 set 2008 | 21 dic 2016 | Sciolta | Amministratore | Wigmore Lane RG7 5HH Theale West Theale Industrial Estate Berkshire | United Kingdom | British | |
| UNITED ASPHALT LIMITED | 15 ago 2007 | 21 dic 2016 | Attiva | Amministratore | West Theale Industrial Estate Wigmore Lane RG7 5HH Theale C/O United Asphalt Limited Berkshire | United Kingdom | British | |
| UNITED ASPHALT LIMITED | 15 ago 2007 | 21 dic 2016 | Sciolta | Amministratore | West Theale Industrial Estate Wigmore Lane RG7 5HH Theale Berkshire | United Kingdom | British | |
| UNITED ASPHALT (CROYDON) LIMITED | 15 ago 2007 | 21 dic 2016 | Sciolta | Amministratore | C/O United Asphalt Limited West Theale Industrial Estate Wigmore Lane Theale Berkshirerg7 5hh | United Kingdom | British | |
| D C AGGREGATES LIMITED | 30 set 2008 | 18 mag 2016 | Attiva | Amministratore | Wigmore Lane RG7 5HH Theale West Theale Industrial Estate Berkshire | United Kingdom | British | |
| INSTITUTE OF QUARRYING(THE) | 06 ott 1995 | 29 set 2008 | Attiva | Amministratore | 3 Claverton Drive Claverton Down BA2 7AJ Bath Banes | United Kingdom | British | |
| FOSTER YEOMAN LIMITED | 01 ago 2004 | 26 giu 2006 | Attiva | Amministratore | 3 Claverton Drive Claverton Down BA2 7AJ Bath Banes | United Kingdom | British | |
| HOLCIM UK HOLDINGS 1 LIMITED | 14 mag 1997 | 30 giu 2003 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CARBON ZERO CONSULTING LTD | 27 mar 2000 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CASTOR PRAXIS CONSULTING LIMITED | 27 mar 2000 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| DOUGLAS CONCRETE LIMITED | 16 mar 1998 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| DOUGLAS CONCRETE HOLDINGS LTD | 16 mar 1998 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| LONDON CONCRETE LIMITED | 18 dic 1997 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| AGGREGATE INDUSTRIES SOUTH WEST LIMITED | 26 ago 1997 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| HOLCIM UK LIMITED | 17 giu 1997 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| RESTORED PROPERTIES LIMITED | 09 giu 1997 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| MENDIP BASALT CO.LIMITED(THE) | 01 mar 1995 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| AI PROPERTIES LIMITED | 01 ago 1994 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CAMAS BUILDING MATERIALS LIMITED | 01 ago 1994 | 02 gen 2001 | Sciolta | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CAMAS HOLDINGS LIMITED | 01 giu 1994 | 02 gen 2001 | Sciolta | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CAMAS UK LIMITED | 09 mag 1994 | 02 gen 2001 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| CAMAS LIMITED | 28 apr 1994 | 02 gen 2001 | Sciolta | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| MINERAL PRODUCTS ASSOCIATION RESTORATION GUARANTEE FUND LIMITED | 21 set 1999 | 11 dic 2000 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| MINERAL PRODUCTS ASSOCIATION LIMITED | 27 apr 1995 | 11 dic 2000 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| THE QMJ GROUP LIMITED | 09 mag 1996 | 06 dic 2000 | Attiva | Amministratore | 6 Beauchamp Avenue CV32 5TA Royal Leamington Spa Warwickshire | British | ||
| ONYX HIGHMOOR LIMITED | 23 set 1997 | 01 lug 1998 | Attiva | Amministratore | 5 Dr Crawfords Close Windmill Road Minchinhampton GL6 9EZ Stroud Gloucestershire | British | ||
| AGGREGATE INDUSTRIES PENSION TRUSTEE LIMITED | 21 ott 1994 | 01 dic 1997 | Sciolta | Amministratore | 5 Dr Crawfords Close Windmill Road Minchinhampton GL6 9EZ Stroud Gloucestershire | British | ||
| ECO-PAC LIMITED | 01 ago 1994 | 23 gen 1997 | Attiva | Amministratore | 5 Dr Crawfords Close Windmill Road Minchinhampton GL6 9EZ Stroud Gloucestershire | British | ||
| AGGREGATE INDUSTRIES SLAS LIMITED | 14 nov 1996 | Attiva | Amministratore | 5 Dr Crawfords Close Windmill Road Minchinhampton GL6 9EZ Stroud Gloucestershire | British | |||
| GEOCYCLE UK LIMITED | 31 mag 1994 | Attiva | Amministratore | Marston House Marston Bigot BA115DU Frome Somerset | British | |||
| MENDIP RAIL LIMITED | 06 ott 1993 | 29 apr 1994 | Attiva | Amministratore | 5 Dr Crawfords Close Windmill Road Minchinhampton GL6 9EZ Stroud Gloucestershire | British | ||
| FOSTER YEOMAN LIMITED | 29 apr 1994 | Attiva | Amministratore | Dulcote House Dulcote BA5 3PZ Wells Somerset | British | |||
| MORVERN SHIPPING AGENCY LIMITED | 29 apr 1994 | Attiva | Amministratore | Marston House Marston Bigot BA115DU Frome Somerset | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0