Andrew James FROUD
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Andrew |
| Secondo nome | James |
| Cognome | FROUD |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 3 |
| Dimesso | 22 |
| Totale | 26 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY PERFECT COLLAGEN LIMITED | 11 set 2015 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | ||
| ALICSUR UK LIMITED | 19 lug 2013 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | ||
| PALMER CLARK LIMITED | 29 mar 2004 | Sciolta | Segretario | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | British | |||
| RLF PROPERTIES LIMITED | 11 feb 1999 | Attiva | Amministratore | Bishopton Lane Bishopton CV37 9QY Stratford-Upon-Avon Bruce Lodge England | England | British | ||
| PALMER CLARK LIMITED | 30 set 2015 | 01 ott 2020 | Attiva | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| MFA 3 LIMITED | 01 ott 2016 | 30 set 2020 | Attiva | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 United Kingdom | England | British | |
| MULBERRY FROUD ASSOCIATES LIMITED | 17 gen 2011 | 30 set 2020 | Attiva | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | |
| MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED | 01 mag 2010 | 30 set 2020 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | |
| SKYVAPES LTD | 08 apr 2015 | 18 ago 2020 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| COSMEDIC SURGICAL LIMITED | 07 dic 2015 | 08 mag 2019 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| JOHN CRONIN SALES LIMITED | 07 set 2017 | 01 ott 2017 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| JOHN CRONIN SALES LIMITED | 04 nov 2015 | 01 lug 2016 | Sciolta | Amministratore | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | England | British | |
| THE SUSAN HERBERT PORTFOLIO LIMITED | 17 lug 2013 | 01 nov 2013 | Attiva | Amministratore | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour The Studio Warwickshire | United Kingdom | British | |
| COTSWOLD FUDGE CO. LIMITED | 12 mar 2008 | 15 mag 2012 | Attiva | Amministratore | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| PALMER CLARK LIMITED | 11 gen 2011 | 31 gen 2011 | Sciolta | Amministratore | The Chapel Chapel Lane Newbold On Stour CV37 8TY Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | |
| MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED | 12 giu 2009 | 01 dic 2009 | Sciolta | Amministratore | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| RETAIL ELITE LTD | 09 nov 2007 | 01 set 2009 | Sciolta | Amministratore | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| CHRIS FORMAN LIMITED | 01 ott 2004 | 01 set 2006 | Sciolta | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| EUROPEAN RETAIL ENGINEERING LIMITED | 16 ott 2001 | 28 feb 2006 | Attiva | Amministratore | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| MFSF LIMITED | 01 set 2003 | 23 ago 2005 | Attiva | Amministratore | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| SUSSEX HOUSE (GLENILLA ROAD) LIMITED | 04 mar 2003 | 31 mar 2005 | Attiva | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| INSPECTION LINK LIMITED | 01 nov 2001 | 17 set 2004 | Sciolta | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| FOUR CORNERS TRADING COMPANY LIMITED | 02 gen 2001 | 01 ott 2003 | Liquidazione | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| KEYSTROKE TYPESETTING & GRAPHIC DESIGN LIMITED | 02 gen 2002 | 15 mag 2003 | Sciolta | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| QUADRACO LIMITED | 18 nov 2001 | 21 nov 2002 | Sciolta | Segretario | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| INSPECTION LINK LIMITED | 03 ott 2000 | 01 nov 2001 | Sciolta | Amministratore | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0