Nimesh Harish DHOKIA
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Nimesh |
| Secondo nome | Harish |
| Cognome | DHOKIA |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 8 |
| Inattivo | 9 |
| Dimesso | 3 |
| Totale | 20 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITANNIA HOMES (LTD) LTD | 23 lug 2025 | Attiva | Amministratore | Kexby Road Glentworth DN21 5DP Gainsborough Low Farm England | England | British | ||
| CYGNET HOUSING LIMITED | 19 mar 2025 | Attiva | Amministratore | The Jubilee Centre 130 Pershore St B5 6ND Birmingham 110e United Kingdom | England | British | ||
| LOUTH FISH & CHIPS LIMITED | 25 lug 2022 | Attiva | Amministratore | Hanover Walk LS3 1AB Leeds Josephs Well Suite 2c West Yorkshire England | England | British | ||
| DHOKIA PROPERTY LIMITED | 17 mag 2022 | Attiva | Amministratore | Hanover Walk LS3 1AB Leeds Josephs Well, Suite 2c West Yorkshire United Kingdom | England | British | ||
| FLOORTARGET LIMITED | 31 gen 2020 | Sciolta | Amministratore | LE2 6BR Leicester 5 Morris Road England | United Kingdom | British | ||
| SAMSON INDUSTRIES LTD | 02 nov 2018 | Sciolta | Amministratore | LE2 6BR Leicester 59 Morris Road Leicestershire England | England | British | ||
| BASKETWATTS LIMITED | 08 gen 2018 | Sciolta | Amministratore | BD4 7BG Bradford 19 Bolling Road West Yorkshire United Kingdom | England | British | ||
| HUNTERS LOUTH LIMITED | 22 nov 2017 | Sciolta | Amministratore | BD4 7BG Bradford 19 Bolling Road West Yorkshire United Kingdom | England | British | ||
| VALENCIA HEALTHCARE LTD | 06 lug 2016 | Attiva | Amministratore | LE2 8AZ Leicester 106 Grace Road Leicestershire United Kingdom | England | British | ||
| GOUDIELOCKS LTD | 10 feb 2016 | Sciolta | Amministratore | Grove Park LE19 1SD Leicester 1 Lewis Court Leicestershire England | England | British | ||
| ST. ALDHELM'S PHARMACY LIMITED | 03 dic 2015 | Attiva | Amministratore | LE2 8AZ Leicester 106 Grace Road Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| SCARLETT PHARMA LTD | 06 ott 2015 | Sciolta | Amministratore | LE2 6BR Leicester 59 Morris Road Leicestershire England | England | British | ||
| BEACON PRIMARY HEALTHCARE LTD | 01 giu 2012 | Sciolta | Amministratore | LE2 6BR Leicester 59 Morris Road Leicestershire England | England | British | ||
| LINCOLN ELITE LTD | 18 ago 2011 | Sciolta | Amministratore | Jubilee Road DN22 7PG Retford 55 Nottinghamshire United Kingdom | England | British | ||
| DRUG DOCTORS LTD | 18 lug 2011 | Sciolta | Amministratore | Uppingham Road Thurnby LE7 9RN Leicester 732 East Midlands | England | British | ||
| WARWICK HEALTHCARE LIMITED | 07 dic 2005 | Attiva | Amministratore | LE2 8AZ Leicester 106 Grace Road Leicestershire England | United Kingdom | British | ||
| WARWICK HEALTHCARE LIMITED | 07 dic 2005 | Attiva | Segretario | LE2 8AZ Leicester 106 Grace Road Leicestershire England | British | |||
| CYGNET HOUSING LIMITED | 18 dic 2024 | 18 mar 2025 | Attiva | Amministratore | The Jubilee Centre 130 Pershore St B5 6ND Birmingham 110e United Kingdom | England | British | |
| ECOGEN EUROPE LTD | 09 mag 2017 | 12 lug 2018 | Sciolta | Amministratore | Grove Park LE19 1SD Leicester 1 Lewis Court Leicestershire England | England | British | |
| ECOGEN EUROPE LTD | 01 giu 2015 | 11 apr 2017 | Sciolta | Amministratore | Grove Park LE19 1SD Leicester 1 Lewis Court Leicestershire England | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0