Alexander Thomas Michael SHIEL
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Alexander |
| Secondo nome | Thomas Michael |
| Cognome | SHIEL |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 3 |
| Dimesso | 12 |
| Totale | 17 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURC LIMITED | 13 ott 2025 | Attiva | Amministratore | Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne 56 England | United Kingdom | British | ||
| TCUK HOMES LIMITED | 08 feb 2017 | Attiva | Amministratore | Eleventh Avenue North Team Valley Trading Estate NE11 0NJ Gateshead H26 The Avenues United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| SANDCO 928 LIMITED | 30 set 2005 | Sciolta | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | |||
| NORTHERN COLLEGE OF HOMEOPATHIC MEDICINE | Sciolta | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||||
| NORTHERN COLLEGE OF HOMEOPATHIC MEDICINE | Sciolta | Amministratore | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | |||
| HELIX ARTS LIMITED | 27 lug 2016 | 01 ago 2025 | Attiva | Amministratore | Saville Street NE30 1NT North Shields 54a England | United Kingdom | British | |
| WARD HADAWAY LLP | 22 apr 2021 | 31 mar 2023 | Attiva | Socio di LLP | 102 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne Sandgate House Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | ||
| MATRIX PRODUCTS LIMITED | 01 mar 2000 | 19 set 2021 | Attiva | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| POWAIR AUTOMATION LIMITED | 22 ott 1999 | 02 apr 2021 | Attiva | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| THE AUTOMATION GROUP LIMITED | 21 ott 1999 | 02 apr 2021 | Attiva | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| ADM AUTOMATION LIMITED | 15 apr 1996 | 02 apr 2021 | Attiva | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| THE CYRENIANS LTD | 01 dic 2003 | 01 dic 2016 | Attiva | Amministratore | Dukesway Team Valley Trading Estate NE11 0LF Gateshead Textile House Tyne And Wear England | United Kingdom | British | |
| CISV INTERNATIONAL LIMITED | 16 dic 1998 | 13 gen 1999 | Attiva | Amministratore | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | |
| CISV INTERNATIONAL LIMITED | 16 dic 1998 | 13 gen 1999 | Attiva | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| ECONOLINER LIMITED | 04 ott 1996 | 19 set 1997 | Sciolta | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| USEFINE LIMITED | 14 ago 1996 | 06 set 1996 | Sciolta | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | ||
| GLOBALSCREEN LIMITED | 14 ago 1996 | 06 set 1996 | Sciolta | Segretario | 56 Queens Road Jesmond NE2 2PR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0