Gareth Stuart NASH
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Gareth |
Secondo nome | Stuart |
Cognome | NASH |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 6 |
Dimesso | 14 |
Totale | 20 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT FOR HOUSING LIMITED | 13 ago 2020 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Cecil Street FY8 5NN Lytham St. Annes 7 England | England | British | |
STEPPING IN2 POSSIBILITIES COMMUNITY INTEREST COMPANY | 07 feb 2018 | Sciolta | Management Consultant | Amministratore | Great Ancoats Street M4 6DE Manchester 132-134 Greater Manchester United Kingdom | England | British | |
WINDOWLESS MONADS LIMITED | 15 gen 2014 | Sciolta | Consultant Director | Amministratore | Cecil Street FY8 5NN Lytham 7 Lancashire England | England | British | |
CONCILIUM CONSULTING COMMUNITY INTEREST COMPANY | 29 giu 2009 | Sciolta | Business Advisor | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British | |
USEFUL WORK LIMITED | 25 giu 2007 | Sciolta | Management Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British | |
4TH DIMENSION CONSULTING LTD | 02 ott 2006 | Sciolta | Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British | |
BROOKFIELD RETROFIT LIMITED | 15 mag 2023 | 10 ago 2023 | Attiva | Business Adviser | Amministratore | Waterside BB3 3PA Darwen 16-17 Victoria Buildings Lancashire United Kingdom | England | British |
MIGRANT SUPPORT | 13 ott 2016 | 07 lug 2022 | Attiva | Consultant And Director | Amministratore | Oldham Street M1 1JQ Manchester Methodist Central Building Lancashire England | England | British |
DEEDS NOT WORDS (PRESTON) LIMITED | 05 gen 2022 | 06 giu 2022 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside BB3 3PA Darwen 16-17 Victoria Buildings England | England | British |
CO-OPERATIVES NORTH WEST LIMITED | 25 ago 2008 | 29 set 2015 | Sciolta | Management Consultant | Amministratore | Mizzy Road OL12 6HW Rochdale 29 Lancashire | England | British |
PRESTON TRANSPORT LTD | 10 feb 2010 | 01 ott 2012 | Sciolta | Consultant | Amministratore | Cecil Street FY8 5NN Lytham St. Annes 7 United Kingdom | England | British |
SOCIAL ENTERPRISE NORTH WEST LIMITED | 23 mag 2008 | 10 gen 2011 | Sciolta | Management Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
CUMBRIA RECYCLING LIMITED | 24 ago 2006 | 27 mag 2010 | Attiva | Consultant | Amministratore | Cecil Street FY8 5NN Lytham 7 Lancashire | England | British |
ENVIRONAPPIES LANCASHIRE LIMITED | 19 ott 2004 | 01 nov 2009 | Sciolta | Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
ENVIRONAPPIES LANCASHIRE LIMITED | 19 ott 2004 | 01 nov 2009 | Sciolta | Consultant | Segretario | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | British | |
SELNET LTD | 22 mag 2008 | 30 giu 2009 | Attiva | Management Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
EMPLOYMENT AND REGENERATION PARTNERSHIP LIMITED | 28 mag 2003 | 30 gen 2009 | Attiva | Director | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
THIRD SECTOR ENTERPRISES LIMITED | 26 gen 2005 | 01 apr 2007 | Sciolta | Consultant | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
LANCASHIRE-GULU LOCAL AGENDA 21 LINK LIMITED | 08 lug 1997 | 04 apr 2002 | Sciolta | Managing Director | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
EDS (NW) LTD | 13 set 1996 | 28 feb 2002 | Sciolta | Director | Amministratore | 7 Cecil Street FY8 5NN Lytham Lancashire | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0