Colin George BARRAL (DECEASED)
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Colin |
| Secondo nome | George |
| Cognome | BARRAL |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 10 |
| Dimesso | 32 |
| Totale | 43 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LIMITED | 27 giu 2017 | Sciolta | Amministratore | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| PROFIT MATTERS CONSULTING LTD | 27 apr 2017 | Attiva | Amministratore | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 | Scotland | British | ||
| @SSAS (UK) LIMITED | 08 ott 2012 | Sciolta | Amministratore | 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow 6th Floor Mercantile Building | Scotland | British | ||
| LEGGAT AVIATION LIMITED | 07 gen 2008 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
| DAVID GARRETT DENTAL SURGERY LTD. | 09 nov 2007 | Sciolta | Segretario | Gordon Chambers 90 Mitchell Street G1 3NQ Glasgow 6th Floor Scotland | British | |||
| K.E. BELL LTD. | 10 lug 2007 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
| ZEN PRODUCTIONS LIMITED | 12 set 2006 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
| REAL RENTING LTD. | 09 giu 2005 | Sciolta | Segretario | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | British | |||
| SECRETARIAL-DATA PEOPLE LTD. | 18 feb 2005 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
| BARRAL FINANCIAL SERVICES LTD | 28 ott 2003 | Sciolta | Segretario | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS | British | |||
| MACKIE REAL ESTATE LIMITED | 14 mag 1999 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
| @SSAS (PENSION TRUSTEES) LTD | 01 apr 2012 | 03 gen 2024 | Attiva | Amministratore | 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow 6th Floor Mercantile Building Scotland | Scotland | British | |
| @SIPP LIMITED | 26 set 2001 | 02 mar 2023 | Attiva | Amministratore | Eaglesham G76 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | Scotland | British | |
| @SIPP (PENSION TRUSTEES) LIMITED | 23 mar 2001 | 02 mar 2023 | Attiva | Amministratore | Eaglesham G76 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | Scotland | British | |
| SPIRIT OF CAIRNGORM LTD | 03 feb 2021 | 01 mar 2023 | Attiva | Amministratore | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | |
| BRITE HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD. | 07 mar 2018 | 01 mar 2023 | Attiva | Amministratore | 5 Newton Terrace G3 7PJ Glasgow Berkeley House Scotland | Scotland | British | |
| BERKELEY CLINIC UK LTD | 07 nov 2017 | 01 mar 2023 | Attiva | Amministratore | Newton Terrace G3 7PJ Glasgow 5 United Kingdom | Scotland | British | |
| BRITE HOLDINGS (SCOTLAND) LIMITED | 21 lug 2017 | 01 mar 2023 | Attiva | Amministratore | 5 Newton Terrace G3 7PJ Glasgow Berkeley House | Scotland | British | |
| FOURPLY LTD. | 21 nov 2015 | 01 mar 2023 | Attiva | Amministratore | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | Scotland | British | |
| FOURPLY SPECIALIST COATINGS LTD. | 17 nov 2008 | 01 mar 2023 | Sciolta | Segretario | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 | British | ||
| THE MARTIN PROPERTY COMPANY LIMITED | 01 dic 2007 | 01 mar 2023 | Attiva | Segretario | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire United Kingdom | British | ||
| I-DENTIFY SCOTLAND LTD. | 20 giu 2005 | 01 mar 2023 | Attiva | Segretario | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS | British | ||
| REAL RENTS LTD. | 15 mar 2005 | 01 mar 2023 | Attiva | Segretario | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire | British | ||
| REAL LETTING LTD. | 25 feb 2003 | 01 mar 2023 | Attiva | Segretario | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | British | ||
| FOURPLY LTD. | 05 feb 2001 | 01 mar 2023 | Attiva | Segretario | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | British | ||
| PANESAR PROPERTIES LTD. | 16 giu 2006 | 28 feb 2021 | Attiva | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
| THE GARTH HOTEL AND LUXURY LODGES LIMITED | 20 mar 2001 | 03 mag 2019 | Sciolta | Segretario | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | British | ||
| HOTEL CONNEXIONS LIMITED | 21 nov 2015 | 05 ago 2016 | Sciolta | Amministratore | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | |
| STRATHCLYDE VULCANISING SERVICES LIMITED | 21 nov 2015 | 20 giu 2016 | Attiva | Amministratore | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | |
| BARRAL SHEPPARD FINANCIAL SERVICES LLP | 24 apr 2015 | 15 mag 2015 | Sciolta | Socio di LLP | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | ||
| @SSAS (PENSION TRUSTEES) LTD | 12 lug 2001 | 01 apr 2012 | Attiva | Segretario | Eaglesham G79 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | British | ||
| BRAEDALE AERIALS LTD | 14 set 2001 | 18 mar 2009 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
| PROFIT COUNTS LIMITED | 14 giu 2004 | 30 set 2008 | Attiva | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
| JCT CONTRACTS LTD. | 21 giu 2006 | 05 set 2008 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
| PREMIER CONSTRUCTION (SCOTLAND) LTD. | 25 apr 2000 | 30 giu 2008 | Sciolta | Segretario | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0