Christopher GRAHAM
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Christopher |
Cognome | GRAHAM |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 3 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 24 |
Totale | 27 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALLSEND MASONIC HALL COMPANY LIMITED(THE) | 28 mar 2019 | Attiva | Solicitor | Amministratore | Masonic Hall Hugh St NE28 6RL Wallsend Tyne & Wear | England | British | |
INSPIRE MULTI ACADEMY TRUST | 24 gen 2019 | Attiva | Consultant | Amministratore | Archer Road Farringdon SR3 3DJ Sunderland Farringdon Academy Tyne And Wear | England | British | |
CITIZENS ADVICE SUNDERLAND | 21 lug 2011 | Attiva | Consultant | Amministratore | Waterloo Place SR1 3HT Sunderland 5a England | England | British | |
EVINCE TECHNOLOGY LIMITED | 01 nov 2011 | 29 ott 2014 | Liquidazione | Consultant | Amministratore | 8 Eversley Place Newcastle Upon Tyne NE6 5AL | England | British |
WALLSEND MASONIC HALL COMPANY LIMITED(THE) | 26 nov 2007 | 20 mar 2014 | Attiva | Company Secretary | Amministratore | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | England | British |
SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED | 19 gen 2010 | 31 dic 2010 | Attiva | Legal Services Director | Amministratore | Glenluce, Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England England | England | British |
SABIC GLOBAL LIMITED | 01 feb 2008 | 31 dic 2010 | Attiva | Legal Services Director | Amministratore | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | England | British |
SABIC GLOBAL LIMITED | 01 gen 2008 | 31 dic 2010 | Attiva | Legal Services Director | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | |
SABIC UK LIMITED | 01 gen 2008 | 31 dic 2010 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
SABIC UK PENSION TRUSTEES LIMITED | 22 feb 2007 | 31 dic 2010 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
SABIC TEES HOLDINGS LIMITED | 29 dic 2006 | 31 dic 2010 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED | 29 dic 2006 | 31 dic 2010 | Attiva | Legal Services Director | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | |
SABIC TEES LIMITED | 15 lug 2008 | 31 dic 2010 | Sciolta | Legal Services Director | Amministratore | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | England | British |
SABIC INTERNATIONAL LIMITED | 01 feb 2008 | 31 dic 2010 | Sciolta | Legal Services Director | Amministratore | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | England | British |
SABIC INTERNATIONAL LIMITED | 01 gen 2008 | 31 dic 2010 | Sciolta | Legal Services Director | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | |
SABIC TEES LIMITED | 05 gen 2007 | 31 dic 2010 | Sciolta | Legal Services Director | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | |
HUNTSMAN PETROCHEMICALS (UK) HOLDINGS | 01 apr 2005 | 11 mag 2005 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
SIEMENS ENERGY LIMITED | 29 feb 2000 | 04 mag 2001 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH (UK) PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED | 23 lug 1999 | 04 mag 2001 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH REYROLLE DISTRIBUTION LIMITED | 27 ott 1998 | 04 mag 2001 | Attiva | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH (UK) LIMITED | 09 gen 2001 | 04 mag 2001 | Sciolta | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH T & D UK LIMITED | 11 ott 2000 | 04 mag 2001 | Sciolta | Head Of Legal Affairs | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | |
VA TECH T & D UK LIMITED | 11 ott 2000 | 04 mag 2001 | Sciolta | Head Of Legal Affairs | Amministratore | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | England | British |
VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED | 29 feb 2000 | 04 mag 2001 | Sciolta | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH SHORT-CIRCUIT LIMITED | 13 mag 1999 | 04 mag 2001 | Sciolta | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
SIEMENS PROTECTION DEVICES LIMITED | 13 mag 1999 | 04 mag 2001 | Sciolta | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British | ||
VA TECH PEEBLES TRANSFORMERS LIMITED | 29 feb 2000 | 11 apr 2001 | Sciolta | Segretario | Glenluce Birtley Chester Le Street DH3 2HY Durham 66 England United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0