Roger Victor John CADBURY
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Roger |
| Secondo nome | Victor John |
| Cognome | CADBURY |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 26 |
| Totale | 28 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILY SERVICE UNITS | 09 dic 1995 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | ||
| GEORGE CADBURY FUND LIMITED(THE) | 17 lug 1995 | Attiva | Amministratore | Two Snowhill 7th Floor B4 6GA Birmingham C/O Bdo Llp United Kingdom | England | British | ||
| BOURNVILLE VILLAGE ENTERPRISES LIMITED | 20 ott 2021 | 09 dic 2021 | Attiva | Amministratore | Bournville Lane Bournville B30 1QY Birmingham 350 England | England | British | |
| BOURNVILLE VILLAGE DEVELOPMENTS LIMITED | 03 ago 1992 | 09 dic 2021 | Attiva | Amministratore | Bournville Lane B30 1QY Birmingham 350 England | England | British | |
| PRIMROSE HILL TRUST FUND LIMITED | 03 mar 2020 | Attiva | Amministratore | Maugersbury GL54 1HR Cheltenham Rowan House Gloucestershire United Kingdom | England | British | ||
| WARWICKSHIRE WILDLIFE TRUST LTD | 01 ott 2015 | Attiva | Amministratore | Maugersbury GL54 1HR Cheltenham Rowan House Gloucestershire | England | British | ||
| AGE UK COVENTRY AND WARWICKSHIRE | 22 mag 2001 | 10 mag 2013 | Attiva | Amministratore | Maugersbury GL54 1HR Cheltenham Rowan House Gloucestershire | England | British | |
| WARWICK INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION | 13 lug 2001 | 09 lug 2012 | Attiva | Amministratore | Myton Road CV34 6PP Warwick Warwick Independent Schools Foundation United Kingdom | England | British | |
| SOIL ASSOCIATION LIMITED(THE) | 24 nov 1996 | 16 nov 2011 | Attiva | Amministratore | South Plaza Marlborough Street BS1 3NX Bristol | England | British | |
| SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED | 06 mag 1993 | 07 lug 2009 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| WARWICK SCHOLARSHIP TRUST | 27 giu 2003 | 29 mag 2008 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| AVONCROFT MUSEUM OF HISTORIC BUILDINGS | 18 giu 1998 | 12 mar 2007 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| WARWICK SCHOOLS ENTERPRISES LIMITED | 23 apr 2004 | 01 set 2006 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| CAMPUS LIBRARY SERVICES LIMITED | 23 apr 2004 | 01 set 2006 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| ARCHANT LIMITED | 28 gen 2002 | 18 mag 2004 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED(THE) | 01 apr 1998 | 31 dic 2002 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| YHA (ENGLAND AND WALES) | 01 apr 1993 | 06 lug 2002 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| NEWSQUEST COMMUNITY MEDIA LIMITED | 27 lug 1993 | 25 mar 2002 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| GROUNDWORK BIRMINGHAM AND SOLIHULL | 04 lug 1996 | 09 lug 2000 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| MIDDLEMARCH ENVIRONMENTAL LIMITED | 22 gen 1998 | 30 mar 1999 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| AGE UK COVENTRY & WARWICKSHIRE (TRADING) LIMITED | 08 mag 1996 | 17 apr 1998 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| PREMIER BRANDS LIMITED | 30 giu 1994 | 15 mar 1996 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| PIFUK OLD CO LIMITED | 30 giu 1994 | 15 mar 1996 | Sciolta | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | |
| WHITWORTH BROS.LIMITED | 31 dic 1992 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | ||
| NAPIER BROWN HOLDINGS LIMITED | 31 dic 1992 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | ||
| F & A GEORGE LIMITED | 31 dic 1992 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | ||
| DOGSTHORPE ACQUISITIONS LIMITED | 31 dic 1992 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British | ||
| INSTITUTE OF GROCERY DISTRIBUTION (THE) | 31 dic 1992 | Attiva | Amministratore | 58 Binswood Avenue CV32 5RX Leamington Spa Warwickshire | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0