Michael William BENNETT
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Michael |
| Secondo nome | William |
| Cognome | BENNETT |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 7 |
| Dimesso | 29 |
| Totale | 37 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLENIUS (UK) LIMITED | 08 set 2006 | Attiva | Segretario | Hippingstones Lane NE45 5JP Corbridge Corrie Lodge Northumberland England | British | |||
| E-INDIGO LIMITED | 25 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | |||
| EC1M LIMITED | 17 nov 2004 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | |||
| JTM PARTNERS LIMITED | 14 nov 2003 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | |||
| S P INTEGRATION (UK) LIMITED | 30 set 2002 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | |||
| 3 K DIGITAL LIMITED | 18 gen 2000 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | |||
| MG MARKETING SERVICES LIMITED | 20 ott 1997 | Sciolta | Segretario | Princes Street NE45 5BZ Corbridge 13 Prince's Court Northumberland United Kingdom | British | |||
| RANDALL WILLIAM ASSOCIATES LIMITED | 10 mar 1997 | Sciolta | Amministratore | Ithaki Ithaki 28301 Kioni | Greece | British | ||
| FIZZBACK LIMITED | 01 giu 2007 | 11 mag 2010 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| MOBILE FEEDBACK LIMITED | 18 mag 2003 | 11 mag 2010 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| THE FIZZBACK GROUP LIMITED | 18 mag 2003 | 05 mar 2010 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| GROENEVELD ICT SOLUTIONS LIMITED | 10 ott 2001 | 10 feb 2010 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| RANDALL WILLIAM ASSOCIATES LIMITED | 25 ott 2007 | 30 set 2009 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| KWR BUSINESS SERVICES LIMITED | 11 ott 2002 | 05 gen 2009 | Sciolta | Amministratore | Flat 4 Kingston House East Princes Lane SW7 1JR London | British | ||
| ALACRITY INVESTMENTS LIMITED | 17 nov 2006 | 30 apr 2008 | Sciolta | Segretario | 4 Newstead Mill Newstead PE9 4TF Stamford Lincolnshire | British | ||
| MAYNARD HOUSE LIMITED | 05 ago 2003 | 10 ago 2007 | Attiva | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| TUFTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 27 mar 2006 | 30 giu 2007 | Attiva | Amministratore | 4 Kingston House East Prince's Gate SW7 1LJ London | British | ||
| OCEANIC MARKETING LIMITED | 16 feb 2007 | 28 mar 2007 | Sciolta | Amministratore | 4 Kingston House East Prince's Gate SW7 1LJ London | British | ||
| TUFTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 20 nov 2003 | 14 mar 2007 | Attiva | Segretario | 4 Kingston House East Prince's Gate SW7 1LJ London | British | ||
| OOLIO GROUP UK LIMITED | 06 set 2002 | 23 gen 2007 | Attiva | Segretario | 4 Kingston House East Prince's Gate SW7 1LJ London | British | ||
| NETXTRA LIMITED | 16 mag 2002 | 09 mar 2004 | Attiva | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| FINDER.CO.UK LIMITED | 19 lug 2001 | 09 mar 2004 | Sciolta | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| NETXTRA LIMITED | 06 ott 2000 | 09 mar 2004 | Attiva | Amministratore | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| LADER SYSTEMS LIMITED | 13 gen 2004 | 15 gen 2004 | Attiva | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| KKR BUSINESS SERVICES LIMITED | 30 set 2002 | 10 lug 2003 | Sciolta | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| PERUCCHETTI PLASTERING LIMITED | 05 lug 2002 | 20 nov 2002 | Sciolta | Segretario | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| CHILDREN WITH AIDS CHARITY | 08 nov 1999 | 03 mar 2002 | Sciolta | Amministratore | 18 Glebe Close Sibsey PE22 0RW Boston Lincolnshire | British | ||
| GROENEVELD ICT SOLUTIONS LIMITED | 02 ago 1999 | 20 nov 2000 | Sciolta | Amministratore | Flat 3 Apsley Hall 55 Balaclava Road KT6 5PN Surbiton Surrey | British | ||
| MCAHRELL & ASSOCIATES LIMITED | 03 set 1999 | 07 set 1999 | Sciolta | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| MARMALADE LONDON LIMITED | 08 giu 1999 | 01 set 1999 | Sciolta | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| GROENEVELD ICT SOLUTIONS LIMITED | 28 mag 1999 | 02 ago 1999 | Sciolta | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| PBMS LIMITED | 14 nov 1997 | 30 giu 1999 | Attiva | Amministratore | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| SKD 19 LIMITED | 13 apr 1999 | 30 apr 1999 | Attiva | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| PLASMA SURGICAL LIMITED | 03 feb 1999 | 03 feb 1999 | Attiva | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British | ||
| L&R MEDICAL UK LTD. | 09 set 1998 | 10 set 1998 | Attiva | Segretario | 13 St Andrews Walk KT11 3EQ Cobham Surrey | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0