Hugo James ADAMS
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Hugo |
Secondo nome | James |
Cognome | ADAMS |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 14 |
Totale | 14 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESTER BUSINESS PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01 ago 2015 | 14 mar 2019 | Attiva | None Stated | Amministratore | Herons Way Chester Business Park CH4 9QL Chester The Lodge Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British |
MARKS AND SPENCER (BRADFORD) LIMITED | 18 feb 2016 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | 35 North Wharf Road W2 1NW London Waterside House United Kingdom | United Kingdom | British |
MARKS & SPENCER SIMPLY FOODS LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (TUNBRIDGE) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
BUSYEXPORT LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (THORNCLIFFE) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (LONG EATON) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
AMETHYST LEASING (PROPERTIES) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
MARKS AND SPENCER (INITIAL LP) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | No 2 Lochrin Square 96 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (HARDWICK) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
MARKS AND SPENCER CHESTER LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (CUMBERNAULD) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
AMETHYST LEASING (HOLDINGS) LIMITED | 10 giu 2014 | 30 nov 2016 | Attiva | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
RUBY PROPERTIES (ENFIELD) LIMITED | 02 lug 2014 | 30 nov 2016 | Sciolta | Director | Amministratore | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0