Michael John SLADE
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Michael |
| Secondo nome | John |
| Cognome | SLADE |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 7 |
| Dimesso | 17 |
| Totale | 24 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESLINGTON STUDIOS LIMITED | 15 lug 2008 | Sciolta | Segretario | Heslington Hall YO10 5DD Heslington Finance Department York England | Other | |||
| YORK CAMPUS PHARMACY LIMITED | 12 mag 2008 | Sciolta | Segretario | Deramore Drive YO10 5HW York 7 North Yorkshire | Other | |||
| BIONIQS LIMITED | 09 feb 2005 | Sciolta | Segretario | 3 Turner's Croft Heslington YO10 5EL York | British | |||
| AMAETHON LIMITED | 08 ott 2004 | Sciolta | Segretario | Peter Lane YO1 8SU York Popeshead Court Offices | Other | |||
| ORIGIN CONSULTING (YORK) LIMITED | 01 ago 2004 | Sciolta | Segretario | Innovation Way Heslington YO10 5DG York Innovation Centre | Other | |||
| YNI LIMITED | 22 giu 2004 | Sciolta | Segretario | Heslington Hall Heslington YO10 5DD York North Yorkshire | British | |||
| YORK UNIVERSITY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 04 feb 1999 | Sciolta | Segretario | Heslington Hall Heslington YO1 5DD York | Other | |||
| YORK SCIENCE PARK LIMITED | 26 lug 2002 | 05 ago 2022 | Attiva | Segretario | Heslington Hall Heslington YO10 5DD York North Yorkshire | Other | ||
| PCMIS HEALTH TECHNOLOGIES LTD | 04 feb 1999 | 05 ago 2022 | Attiva | Segretario | Heslington Hall Heslington YO10 5DD York | British | ||
| YORK UNIVERSITY ENERGY SUPPLY COMPANY LIMITED | 04 feb 1999 | 05 ago 2022 | Attiva | Segretario | Heslington Hall Heslington YO10 5DD York | Other | ||
| YORK COMMERCIAL LIMITED | 04 feb 1999 | 05 ago 2022 | Attiva | Segretario | Heslington YO10 5DD York Heslington Hall | Other | ||
| YORK UNIVERSITY PROPERTY COMPANY LIMITED | 04 feb 1999 | 05 ago 2022 | Attiva | Segretario | University Of York Heslington YO10 5DD York North Yorkshire | Other | ||
| PARAYTEC LIMITED | 25 gen 2005 | 17 dic 2019 | Attiva | Segretario | Outgang Lane Osbaldwick YO19 5UP York York House North Yorkshire | Other | ||
| CIZZLE BIOTECHNOLOGY LIMITED | 12 mag 2006 | 17 mag 2019 | Attiva | Segretario | Heslington Hall Heslington YO10 5DD York North Yorkshire | British | ||
| WHITE HART HOTEL (HARROGATE) LIMITED | 02 lug 2008 | 22 ott 2009 | Sciolta | Segretario | Deramore Drive YO10 5HW York 7 North Yorkshire | Other | ||
| GLOBAL TELECOMMUNICATION LABORATORIES LIMITED | 04 mag 2007 | 07 lug 2009 | Sciolta | Segretario | 3 Turner's Croft Heslington YO10 5EL York | British | ||
| EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONIC UK LIMITED | 15 gen 2007 | 07 lug 2009 | Attiva | Segretario | Deramore Drive YO10 5HW York 7 North Yorkshire | Other | ||
| PCT SHAREHOLDERS LIMITED | 09 ago 2001 | 06 giu 2007 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| YCC LIMITED | 01 feb 1999 | 25 apr 2006 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| CBAMS LIMITED | 13 ago 2002 | 10 apr 2006 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| XCELERON LIMITED | 26 giu 2002 | 01 giu 2005 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| STEM LEARNING LIMITED | 03 giu 2004 | 12 ott 2004 | Attiva | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| CARAFILTRATION LIMITED | 02 ott 2001 | 30 lug 2004 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British | ||
| CARAFILTRATION LIMITED | 16 mar 1999 | 21 nov 2000 | Sciolta | Segretario | 15 Lime Avenue YO31 1BT York | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0