Michael Andrew TUCKER
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Michael |
| Secondo nome | Andrew |
| Cognome | TUCKER |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 11 |
| Dimesso | 22 |
| Totale | 34 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWTU PHARMA CONSULT LTD | 17 dic 2016 | Attiva | Amministratore | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | United Kingdom | British | ||
| HEALTHY IDEAS LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| GALPHARM TRADING LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| HEALTHY IDEAS LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| GALPHARM TRADING LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| ENPROFEN LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PAN-EUROPEAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PAN-EUROPEAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| ENPROFEN LIMITED | 09 gen 2008 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| BARUM LIMITED | 30 giu 2005 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| WRAFTON TRUSTEES LIMITED | 16 mag 1998 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| BARUM LIMITED | 16 mag 1998 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PRIMROSE TOPCO LIMITED | 19 giu 2020 | 22 mag 2025 | Attiva | Amministratore | Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street LS11 9XE Leeds Rosemont House England | United Kingdom | British | |
| PRIMROSE BIDCO LIMITED | 19 giu 2020 | 22 mag 2025 | Attiva | Amministratore | Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street LS11 9XE Leeds Rosemont House England | United Kingdom | British | |
| THE NORTH DEVON BIOSPHERE FOUNDATION | 30 set 2019 | 04 gen 2022 | Attiva | Amministratore | Spring Close Northam EX39 1TY Bideford 2 Devon England | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT GROUP LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT HOLDINGS LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT TRUSTEE COMPANY LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ACACIA BIOPHARMA LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT PENSIONS LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | 11 feb 2013 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO UK ACQUISITION LIMITED | 06 mar 2009 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO PHARMA LIMITED | 17 giu 2008 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| KITEACRE LIMITED | 09 gen 2008 | 31 ott 2016 | Sciolta | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | 09 gen 2008 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| GALPHARM INTERNATIONAL LIMITED | 09 gen 2008 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| WRAFTON LABORATORIES LIMITED | 01 nov 2002 | 31 ott 2016 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO PHARMA LIMITED | 17 giu 2008 | 27 mag 2014 | Attiva | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| KITEACRE LIMITED | 09 gen 2008 | 27 mag 2014 | Sciolta | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | 09 gen 2008 | 27 mag 2014 | Attiva | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| GALPHARM INTERNATIONAL LIMITED | 09 gen 2008 | 27 mag 2014 | Attiva | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| WRAFTON LABORATORIES LIMITED | 16 mag 1998 | 27 mag 2014 | Attiva | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| BRUNEL HEALTHCARE MANUFACTURING LIMITED | 11 dic 2003 | 17 giu 2008 | Attiva | Segretario | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| BRUNEL HEALTHCARE MANUFACTURING LIMITED | 11 dic 2003 | 17 giu 2008 | Attiva | Amministratore | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0