Graham PAYTON
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Graham |
| Cognome | PAYTON |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 0 |
| Inattivo | 4 |
| Dimesso | 29 |
| Totale | 33 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDGE 1098 LIMITED | 16 ago 2013 | Sciolta | Amministratore | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House | United Kingdom | British | ||
| RIVER OAKS (FOODS) LIMITED | 22 ott 2007 | Sciolta | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | ||
| AQUINO RESTAURANT COMPANY LIMITED | 22 ott 2007 | Sciolta | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | ||
| CRAIG GROUP LEISURE LIMITED | 22 ott 2007 | Sciolta | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | ||
| CRAIG INTERNATIONAL SUPPLIES LIMITED | 16 feb 2016 | 13 feb 2018 | Attiva | Amministratore | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| GRAMPIAN GOLF & LEISURE ASSOCIATES LIMITED | 01 mag 2010 | 13 feb 2018 | Attiva | Amministratore | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| CRAIG ENERGY SERVICES LIMITED | 10 set 2009 | 13 feb 2018 | Attiva | Amministratore | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| CRAIG INTERNATIONAL LIMITED | 14 feb 2008 | 13 feb 2018 | Attiva | Amministratore | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| NORTH STAR SHIPPING (ABERDEEN) LIMITED | 09 apr 2010 | 02 nov 2017 | Attiva | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| CREWING SERVICES (ABERDEEN) LIMITED | 22 ott 2007 | 02 nov 2017 | Attiva | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | |
| NORTH STAR HOLDCO LIMITED | 22 ott 2007 | 02 nov 2017 | Attiva | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | |
| GRAMPIAN SEA FISHING LIMITED | 30 ott 2008 | 03 mar 2011 | Attiva | Amministratore | Queens Road AB15 4ZT Aberdeen 12 Scotland | United Kingdom | British | |
| BHD GROUP LIMITED | 20 lug 2004 | 11 ago 2004 | In amministrazione controllata | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| NIKON METROLOGY UK LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Attiva | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| NIKON METROLOGY UK LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Attiva | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| LK GROUP LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Sciolta | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| LK GROUP LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Sciolta | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| LK INVESTMENTS LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Sciolta | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| LK INVESTMENTS LIMITED | 27 set 1999 | 31 ago 2003 | Sciolta | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| 03088350 LIMITED | 16 ago 1995 | 04 mar 1999 | Attiva | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| 03088350 LIMITED | 16 ago 1995 | 04 mar 1999 | Attiva | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| EDGBASTON GROUP LIMITED | 24 lug 1995 | 04 mar 1999 | Sciolta | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| EDGBASTON GROUP LIMITED | 24 lug 1995 | 04 mar 1999 | Sciolta | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| PEERLESS STAMPINGS LIMITED | 16 ago 1995 | 14 nov 1995 | Attiva | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| PEERLESS STAMPINGS LIMITED | 16 ago 1995 | 14 nov 1995 | Attiva | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| H E METALS LIMITED | 16 ago 1995 | 24 ott 1995 | Sciolta | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| H E METALS LIMITED | 16 ago 1995 | 24 ott 1995 | Sciolta | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| UNITED STEELS LIMITED | 01 set 1993 | 27 lug 1995 | Attiva | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| UNITED STEELS LIMITED | 01 set 1993 | 27 lug 1995 | Attiva | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| ELWELL SECTIONS LIMITED | 01 set 1993 | 27 lug 1995 | Sciolta | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | |
| ELWELL SECTIONS LIMITED | 01 set 1993 | 27 lug 1995 | Sciolta | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | ||
| B C D COLD ROLLED STRIP LIMITED | 27 lug 1995 | Attiva | Segretario | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | British | |||
| B C D COLD ROLLED STRIP LIMITED | 27 lug 1995 | Attiva | Amministratore | 1 Foley Road Pedmore DY9 0RT Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0