Hugh Francis Dering STURGES
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Hugh |
| Secondo nome | Francis Dering |
| Cognome | STURGES |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 3 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 24 |
| Totale | 28 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMESBURY SCHOOL TRUST LIMITED | 21 feb 2022 | Attiva | Amministratore | Amesbury School Hazel Grove GU26 6BL Hindhead Surrey | England | British | ||
| POND MEADOW ACADEMY TRUST | 04 set 2020 | Attiva | Amministratore | Larch Avenue GU1 1DR Guildford Pond Meadow School Surrey | England | British | ||
| JEROBOAMS GROUP LIMITED | 01 set 2015 | Attiva | Amministratore | 43 Portland Road London W11 4LJ | England | British | ||
| LAYTONS HOLDINGS LIMITED | 01 set 2015 | Sciolta | Amministratore | Conduit Place W2 1EP London 24 | England | British | ||
| MR. CHRISTIAN'S LIMITED | 01 set 2015 | 26 ago 2021 | Attiva | Amministratore | Portland Road W11 4LJ London 43 | England | British | |
| JEROBOAMS LIMITED | 01 set 2015 | 26 ago 2021 | Attiva | Amministratore | 43 Portland Road London W11 4LJ | England | British | |
| JEROBOAMS TRADE LIMITED | 01 set 2015 | 26 ago 2021 | Attiva | Amministratore | 43 Portland Road London W11 4LJ | England | British | |
| JEROBOAMS SHOPS LIMITED | 01 set 2015 | 26 ago 2021 | Attiva | Amministratore | 43 Portland Road London W11 4LJ | England | British | |
| THE WINE AND SPIRIT TRADE ASSOCIATION | 18 apr 2007 | 02 mar 2015 | Attiva | Amministratore | International Wine & Spirit Centre, 39-45 Bermondsey Street SE1 3XF London | United Kingdom | British | |
| THE GLENROTHES DISTILLERY COMPANY LIMITED | 10 feb 2012 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | Manse Brae Rothes AB38 7AF Aberlour Rothes House Banffshire Scotland | England | British | |
| BB&R US LIMITED | 13 mag 2010 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | St James's Street SW1A 1EG London 3 United Kingdom | England | British | |
| RUDDBERRY LIMITED | 06 apr 2006 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | St James's Street SW1A 1EG London 3 | England | British | |
| 1698 LIMITED | 01 apr 2006 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | St. James's Street SW1A 1EG London 3 | England | British | |
| BERRY BROS. & RUDD LIMITED | 21 lug 2005 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | 3 St James's Street London SW1A 1EG | England | British | |
| BB&R LIMITED | 28 giu 2005 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | 3 St James's Street London SW1A 1EG | England | British | |
| MORRIS AND VERDIN LIMITED | 26 nov 2003 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | 3 St James's Street London SW1A 1EG | England | British | |
| BERRUD LIMITED | 20 mar 2003 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | 1 Pickering Place London SW1A 1EA | England | British | |
| BB&R SPIRITS LIMITED | 12 giu 2001 | 17 feb 2015 | Attiva | Amministratore | 3 St James's Street London SW1A 1EG | England | British | |
| BERRY BROS. & RUDD LIMITED | 24 giu 2005 | 01 apr 2006 | Attiva | Segretario | Hanily,8 Stonedene Close Headley Down GU35 8HW Grayshott Hampshire | British | ||
| BB&R SPIRITS LIMITED | 01 mag 2001 | 01 apr 2006 | Attiva | Segretario | Hanily,8 Stonedene Close Headley Down GU35 8HW Grayshott Hampshire | British | ||
| BERRUD LIMITED | 01 mag 2001 | 20 giu 2005 | Attiva | Segretario | Hanily,8 Stonedene Close Headley Down GU35 8HW Grayshott Hampshire | British | ||
| 1698 LIMITED | 01 mag 2001 | 07 mar 2005 | Attiva | Segretario | Hanily,8 Stonedene Close Headley Down GU35 8HW Grayshott Hampshire | British | ||
| MORRIS AND VERDIN LIMITED | 26 nov 2003 | 06 lug 2004 | Attiva | Segretario | Hanily,8 Stonedene Close Headley Down GU35 8HW Grayshott Hampshire | British | ||
| XITAN LTD. | 01 giu 2000 | 31 ago 2000 | Sciolta | Segretario | 70 Vale Road KT10 0NL Claygate Surrey | British | ||
| NORTHAMBER PLC | 27 mar 2000 | 04 ago 2000 | Attiva | Segretario | 70 Vale Road KT10 0NL Claygate Surrey | British | ||
| GM2 SERVICES LIMITED | 04 ago 2000 | Sciolta | Amministratore | 70 Vale Road KT10 0NL Claygate Surrey | British | |||
| MCNAUGHTON GRAPHICAL PAPER LIMITED | 01 ago 1998 | 08 feb 1999 | Sciolta | Segretario | 70 Vale Road KT10 0NL Claygate Surrey | British | ||
| MCNAUGHTON GRAPHICAL PAPER LIMITED | 08 feb 1999 | Sciolta | Amministratore | 70 Vale Road KT10 0NL Claygate Surrey | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0