Elizabeth Anne PEARCE
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Elizabeth |
Secondo nome | Anne |
Cognome | PEARCE |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 6 |
Dimesso | 13 |
Totale | 19 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERITAGE BUSINESS PARK LIMITED | 16 mag 2002 | Sciolta | Director | Amministratore | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | England | British | |
HERITAGE BUSINESS PARK LIMITED | 16 mag 2002 | Sciolta | Director | Segretario | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | British | ||
SLEEPING GIANT LIMITED | 28 lug 1994 | Sciolta | Director | Amministratore | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | England | British | |
PREMIER SEALS LIMITED | 28 lug 1994 | Sciolta | Director | Amministratore | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | England | British | |
SLEEPING GIANT LIMITED | Sciolta | Segretario | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | British | ||||
PREMIER SEALS LIMITED | Sciolta | Segretario | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | British | ||||
FAVERGILL HOLDINGS LIMITED | 16 gen 1998 | 04 ott 2013 | Attiva | Segretario | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | British | ||
FAVERGILL HOLDINGS LIMITED | 16 gen 1998 | 04 ott 2013 | Attiva | Company Director | Amministratore | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | England | British |
FAVERGILL LIMITED | 28 lug 1994 | 04 ott 2013 | Attiva | Director | Amministratore | Montserrat Road PO13 9LT Lee-On-The-Solent 27 Hampshire England | England | British |
FAVERGILL LIMITED | 04 ott 2013 | Attiva | Segretario | Montserrat Road PO13 9LT Lee-On-The-Solent 27 Hampshire England | British | |||
HERITAGE BUSINESS PARK MANAGEMENT LIMITED | 16 mar 2007 | 02 ott 2009 | Attiva | Segretario | The Badgers 81 Manor Way PO13 9JQ Lee On The Solent Hampshire | British | ||
LIGHT-DOME ROAD MARKER INSERTS LIMITED | 23 dic 1994 | 26 nov 1999 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | |
LIGHT-DOME ROAD MARKER INSERTS LIMITED | 23 dic 1994 | 26 nov 1999 | Attiva | Company Secretary | Amministratore | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | |
INDUSTRIAL RUBBER HOLDINGS LIMITED | 16 gen 1998 | 18 feb 1998 | Sciolta | Segretario | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | ||
INDUSTRIAL RUBBER HOLDINGS LIMITED | 16 gen 1998 | 18 feb 1998 | Sciolta | Company Director | Amministratore | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | |
SILICONE POLYMERS LIMITED | 31 ott 1996 | 18 feb 1998 | Sciolta | Director | Segretario | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | |
SILICONE POLYMERS LIMITED | 31 ott 1996 | 18 feb 1998 | Sciolta | Director | Amministratore | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | |
INDUSTRIAL RUBBER PROPERTIES LTD | 18 feb 1998 | Sciolta | Company Secretary | Amministratore | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British | ||
INDUSTRIAL RUBBER PROPERTIES LTD | 18 feb 1998 | Sciolta | Segretario | 27 Anglesey Road PO12 2EG Gosport Hampshire | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0