William Andrew Joseph TESTER
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | William |
Secondo nome | Andrew Joseph |
Cognome | TESTER |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 6 |
Dimesso | 6448 |
Totale | 6454 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARTSWOOD TEXTILES LIMITED | 28 ott 2016 | 01 set 2018 | Attiva | Director | Amministratore delegato nominato | Regent Street 1st Floor W1B 2HA London Roxburghe House 273-287 England | United Kingdom | British |
HARTSWOOD INVEST SERVICES LIMITED | 16 ott 2014 | 01 set 2018 | Attiva | Director | Amministratore delegato nominato | Georges Road Holloway N7 8EZ London Flat 4 Geary House England | United Kingdom | British |
ZARUBEZHVODSTROY LIMITED | 27 ott 2016 | 01 set 2018 | Sciolta | Business Man | Amministratore delegato nominato | Second Floor, Berkeley Square House Berkeley Square W1J 6BD London Berkeley Square House W1j 6bd England | United Kingdom | British |
QLS AUTOBUS LIMITED | 26 ott 1999 | 02 giu 2016 | Sciolta | Manager | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
RATINGS SELLERS CORP LTD | 18 giu 2013 | 24 mar 2015 | Sciolta | Businessman | Amministratore delegato nominato | Geary House Georges Road Holloway N7 8EZ London 4 England | United Kingdom | British |
40/42 APPLEDORE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 11 mag 2006 | 30 mag 2012 | Attiva | Director | Amministratore delegato nominato | Georges Road Holloway N7 8EZ London 4 Geary House | United Kingdom | British |
9 REDINGTON ROAD LIMITED | 23 ago 1993 | 05 nov 2010 | Attiva | Business Transfer Agent | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
CHESWOOD DRIVE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 10 dic 2003 | 04 ott 2010 | Attiva | Director | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
HOLTON REACH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 03 feb 2005 | 09 mar 2010 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
IKON ALUMINIUM SOLUTIONS (HOLDINGS) LIMITED | 11 gen 2002 | 29 mag 2009 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
BATHROOM LIGHTING LIMITED | 31 mag 2001 | 29 mag 2009 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
THE WAREHOUSE (SE1) LIMITED | 16 mag 2008 | 29 mag 2009 | Sciolta | Director | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
OWL FILM PRODUCTIONS LIMITED | 28 nov 2005 | 29 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
ST. MARTINS INVESTMENTS LIMITED | 17 set 2004 | 29 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
BERMONDSEY CROSS LIMITED | 09 ago 2004 | 29 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
MARTIN JACOB INVESTMENTS LIMITED | 29 lug 2003 | 29 mag 2009 | Sciolta | Director | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
RANGEDROP LIMITED | 12 ago 2002 | 29 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
MILLENNIUM ADJUSTERS LIMITED | 26 ott 1998 | 29 mag 2009 | Sciolta | Director | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
SPLIT D PROPERTIES LIMITED | 27 ago 2004 | 30 set 2008 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
8 SECURITIES LIMITED | 22 giu 2006 | 13 mag 2008 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
8 HEALTHCARE LIMITED | 22 giu 2006 | 13 mag 2008 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
NEW CAUSEWAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 26 set 2005 | 12 mag 2008 | Attiva | Local Authority Searches Co-Ordinator | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
IMPACT INKJET & TONER RECYCLER LIMITED | 28 mar 2006 | 02 feb 2008 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
CWRT PENRHWITYN 2 MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17 lug 2006 | 15 set 2007 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
LUTON TOWN FOOTBALL CLUB (CASINO) LIMITED | 18 lug 2006 | 08 ago 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
BANHAM PROTEINS LIMITED | 11 mag 2006 | 26 lug 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
DREAMSPORTS LIMITED | 11 mag 2006 | 23 lug 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
CHANNEL EVENTS LIMITED | 10 mag 2006 | 31 mag 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
SPORTEC LIMITED | 07 set 2005 | 14 mag 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
137 HURLINGHAM ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 04 ago 2005 | 10 mag 2007 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
RHAPSODY TRAVEL LIMITED | 10 mag 2006 | 30 apr 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
GUMALS LIMITED | 21 ago 2003 | 23 apr 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
OSBORNE HOUSE (LITTLESTONE) LIMITED | 07 ott 2004 | 05 apr 2007 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
BANK (CLAYGATE) LIMITED | 04 mag 2006 | 08 mar 2007 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British | |
JUNCTION HUCKNALL MANAGEMENT CO. LIMITED | 14 feb 2006 | 01 feb 2007 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 4 Geary House Georges Road N7 8EZ London | United Kingdom | British |
23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0