Graham Ronald MOORE
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Graham |
| Secondo nome | Ronald |
| Cognome | MOORE |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 5 |
| Dimesso | 9 |
| Totale | 16 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDG PROPERTIES (WM) LIMITED | 01 dic 2008 | Attiva | Amministratore | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Somerset | United Kingdom | British | ||
| WIGGINTON ESTATES LIMITED | 14 nov 2008 | Sciolta | Segretario | Millfield House Mill Lane WS14 0DW Shenstone The Office Staffs England | British | |||
| WIGGINTON ESTATES LIMITED | 14 nov 2008 | Sciolta | Amministratore | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | |||
| DDG PROPERTIES LIMITED | 22 gen 2003 | Attiva | Amministratore | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Avon United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| WODEN DEVELOPMENTS (WEST BROMWICH) LIMITED | 01 ott 1997 | Sciolta | Segretario | 124 Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court West Midlands | British | |||
| WINCHESTER LEISURE LIMITED | 24 apr 1997 | Sciolta | Segretario | Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court 124 West Midlands | British | |||
| DORCHESTER TAVERNS LIMITED | 28 feb 1997 | Sciolta | Segretario | Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court 124 West Midlands | British | |||
| WIGGINTON DEVELOPMENTS LLP | 22 apr 2009 | 05 apr 2016 | Sciolta | Socio designato di LLP | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a United Kingdom | United Kingdom | ||
| WODEN DEVELOPMENTS LIMITED | 09 set 1998 | 31 mag 2011 | Sciolta | Segretario | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Avon United Kingdom | British | ||
| DORCHESTER LAND LIMITED | 12 dic 2003 | 19 mag 2011 | Sciolta | Segretario | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a | British | ||
| TAMAR GROUP LIMITED | 02 feb 2006 | 05 giu 2006 | Sciolta | Segretario | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| ANNESLEY DEVELOPMENTS LIMITED | 06 feb 2006 | 23 mar 2006 | Sciolta | Segretario | Millfield House Mill Lane WS14 0DW Shenstone The Office Staffs England | British | ||
| NORBURY SPECIALIST CONTRACTS LTD. | 06 feb 2006 | 01 mar 2006 | Sciolta | Segretario | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| NORTH PARK (UK) LIMITED | 16 apr 2003 | 26 set 2003 | Sciolta | Segretario | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| SOUTH HANDFORD DEVELOPMENT LIMITED | 22 lug 1998 | 08 mag 2002 | Attiva | Segretario | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| TAMAR (SELBY) LIMITED | 25 ott 2001 | 06 nov 2001 | Attiva | Segretario | Torrington House 75 Branston Road DE14 3BY Burton On Trent | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0