Gareth Michael CADWALLADER
  • Dati
  • Gran Bretagna
  • Aziende
  • Cerca aziende
  • Sanzioni
  • Cerca sanzioni
  • Gareth Michael CADWALLADER

    Persona fisica

    TitoloMr
    NomeGareth
    Secondo nomeMichael
    CognomeCADWALLADER
    Data di nascita
    È un dirigente societarioNo
    Incarichi
    Attivo0
    Inattivo10
    Dimesso18
    Totale28

    Incarichi

    Incarichi assegnati
    Nominato aData di nominaData di dimissioniStato della societàProfessioneRuoloIndirizzoPaese di residenzaNazionalità
    AI-LONDON INSURTECH LTD12 ago 2020ScioltaBusiness ConsultantAmministratore
    Vicarage Lane
    E15 4HF Stratford
    1
    London
    England
    EnglandBritish
    CONDUCTECH LIMITED22 giu 2017ScioltaDirectorAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    HUGHENDEN VINEYARD LIMITED05 mag 2017ScioltaDirectorAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    BETCLEARER LIMITED28 ago 2012ScioltaNoneAmministratore
    Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    The White House
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish
    APOLLO LEGACY LIMITED05 nov 2010ScioltaBusiness ManagerAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brand House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    SCIDOX LIMITED05 nov 2010ScioltaBusiness ManagerAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    SOPHROSYNE VENTURES LLP23 apr 2009ScioltaSocio designato di LLP
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    England
    AIRAS INTERSOFT LIMITED16 dic 2005ScioltaSegretario
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    British
    AIRAS INTERSOFT LIMITED16 dic 2005ScioltaDirectorAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    THE OBLONG OFFICE LIMITED01 ott 2002ScioltaCompany DirectorAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    DOX PRODUCTIONS LIMITED01 ott 199830 gen 2025AttivaBusiness ManagerAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    LUMERA LONDON LTD30 ott 200631 ott 2024AttivaBusiness ConsultantAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    LUMERA LONDON LTD10 gen 200631 ott 2024AttivaBusiness ConsultantSegretario
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    British
    R M P ENTERPRISE LIMITED01 ago 201221 dic 2022AttivaInvestment ManagerAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    PRECISIONPOINT SOFTWARE LIMITED12 apr 201012 lug 2022AttivaCompany DirectorAmministratore
    Four Ashes
    HP15 6LH Hughenden
    Brands House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    AKKROO SOLUTIONS LIMITED01 mar 201812 apr 2019AttivaDirectorAmministratore
    Brighton Terrace
    SW9 8DJ London
    Unit 3.01 Piano House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    DACAST LIMITED01 nov 201012 mar 2019AttivaCompany DirectorAmministratore
    31-33 Bondway Vauxhall
    SW8 1SJ London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish
    AKKROO SOLUTIONS LIMITED01 lug 201628 nov 2016AttivaInvestment ManagerAmministratore
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    NATURAL NEUTRACEUTICALS LIMITED30 nov 201117 ott 2013ScioltaCompany DirectorAmministratore
    45-47 Tower Street
    Edinburgh
    EH6 7BN
    EnglandBritish
    PULSANT LIMITED29 ott 200530 set 2011AttivaDirectorAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    APPSENSE HOLDINGS LIMITED04 gen 201023 mar 2011LiquidazioneCompany DirectorAmministratore
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4HS Warrington
    3300
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CLOSER PARTNERS LLP17 mar 200519 apr 2010ScioltaSocio designato di LLP
    The White House
    Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont
    England
    SECTOR SKILLS DEVELOPMENT AGENCY LIMITED29 apr 200228 apr 2008ScioltaCompany DirectorAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    APPSENSE HOLDINGS LIMITED18 nov 200525 mar 2008LiquidazioneDirectorAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    THE TECH PARTNERSHIP16 giu 200027 feb 2004ScioltaBusiness ManagerAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    ENTERPRISE SERVICES INFORMATION SECURITY UK LIMITED04 gen 200124 ott 2002AttivaCompany ManagerAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    ZOOM ENTERPRISES LIMITED22 mar 199411 feb 2000AttivaGeneral MangerAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    CABLE & WIRELESS WORLDWIDE VOICE MESSAGING LIMITED20 mar 199512 set 1995ScioltaManaging DirectorAmministratore
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0