FINE FARE PROPERTIES LIMITED

FINE FARE PROPERTIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaFINE FARE PROPERTIES LIMITED
    Estado da empresaConvertida/Fechada
    Forma jurídicaConvertida ou extinta
    Número da empresa 00002907
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    • (7020) /

    Onde fica FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    AERATED BREAD COMPANY LIMITED28/10/186228/10/1862

    Quais são as últimas contas de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em04/01/2011
    Próximas contas vencem em04/10/2011
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até02/01/2010

    Quais são as últimas submissões para FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Certificado de registo de uma sociedade de socorros mútuos

    páginasCERTIPS

    Diversos

    Forms b and z- conversion to I &ps
    páginasMISC

    Resoluções

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Nomeação de Mr Stephen Parry como secretário

    páginasAP03

    Declaração anual preparada até 01/09/2010 com lista completa de acionistas

    páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/09/2010

    Estado do capital em 14/09/2010

    • Capital: GBP 20,045,030
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 02/01/2010

    páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Timothy Hurrell em 01/08/2010

    páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Humes em 01/08/2010

    páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ em 23/02/2010

    páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 02/05/2009

    páginasAA

    Exercício contabilístico atual encurtado de 30/04/2010 para 04/01/2010

    páginasAA01

    Renúncia do auditor

    páginasAUD

    Término da nomeação de William Robson como diretor

    páginasTM01

    Nomeação de Mrs Caroline Jane Sellers como secretário

    páginasAP03

    Término da nomeação de Emily Martin como secretário

    páginasTM02

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288a

    Contas anuais preparadas até 26/04/2008

    páginasAA

    legacy

    páginas363a

    Contas anuais preparadas até 28/04/2007

    páginasAA

    Quem são os diretores de FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretário
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154611440001
    SELLERS, Caroline Jane
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    Secretário
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    146911920001
    HUMES, Stephen
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Secretário
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Secretário
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secretário
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    British91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secretário
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    British115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Diretor
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    British45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Diretor
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritish85825120001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Diretor
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Diretor
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    British111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Diretor
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritish60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Diretor
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    British59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Diretor
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritish37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Diretor
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    British33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Diretor
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    British91828160003
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    British1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    British5435750001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Diretor
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Diretor
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    British777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Diretor
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    British46000100003
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Diretor
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    British61599510002

    FINE FARE PROPERTIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Standard security
    Criado em 08/10/1993
    Entregue em 18/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H subjects at unit 1/2 (otherwise 182) township centre easterhouse glasgow t/no GLA101661.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined in the Charge)
    Transações
    • 18/10/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Criado em 06/09/1993
    Entregue em 24/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descrição
    Car park at weaver row srirling.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 24/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Criado em 06/09/1993
    Entregue em 24/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite gaurantee and debenture
    Breve descrição
    1588 great western road anniesland glasgow title no GLA100884.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedasagent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 24/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Criado em 06/09/1993
    Entregue em 24/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Breve descrição
    Subjects at new cross centre hamilton,l/h subjects at 88 graham street airdrie title no LAN95127,l/h subjects at 275/277 main street bellshill title no LAN95128,l/h subjects at 28/32 the plaza town centre east kilbride title no LAN95129,l/h subjects at 300 victoria road glasgow title no GLA100883,l/h subjects forming part of shillinghill alloa.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 24/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Criado em 06/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trusteee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture dated 05/07/93
    Breve descrição
    Area of ground in sinclair street helensburgh title no DMB11150 subjects under title no DMB16528 subjects on the south west side of carrochan road and north west side of lomond road balloch title no DMB18240.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Criado em 02/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Shop premises at high street lochee dundee.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotlands 02/09/93
    Criado em 02/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Retaildevelopment at high street cowdenbeath.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Criado em 02/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    101/105 high street invergordon.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Criado em 02/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Retail store at 46/48 high street alness.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Criado em 02/09/1993
    Entregue em 22/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Subjects at shillinghill alloa and dingwall,l/h 15/17 and 26 main street prestwick,l/h 485 great western road aberdeen,l/h 26/30 swan street brechin,l/h 45 castle street forfar,l/h 114 dalry road edinburgh,l/h 23 unicorn way glenrothes,subjects at grampian road aviemore.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transações
    • 22/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 27/07/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 05/07/1993
    Entregue em 16/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined)
    Breve descrição
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transações
    • 16/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 18/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 13/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed
    Criado em 05/07/1993
    Entregue em 15/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the lenders in respect of a guarantee & debenture dated 25/10/89 as amended by a supplemental deed dated 05/07/93
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee
    Transações
    • 15/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 18/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 13/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security
    Criado em 19/09/1991
    Entregue em 04/10/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee (under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 and the charge
    Breve descrição
    Subjects k/a new cross centre, hamilton. (For full details refer to doc 395 ref M216C).
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transações
    • 04/10/1991Registro de uma garantia
    Standard security
    Criado em 19/09/1991
    Entregue em 02/10/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 25.10.1991
    Breve descrição
    Shillinghill place alloa and others.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transações
    • 02/10/1991Registro de uma garantia (395)
    Standard security
    Criado em 19/09/1991
    Entregue em 26/09/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 & all other security documents
    Breve descrição
    Area of ground at sinclair st, helensburgh county of dumbarton title no dmb 11150 & lease by strathclyde regional council in favour of the fine fare limited title no dmb 16528.
    Pessoas com direito
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transações
    • 26/09/1991Registro de uma garantia
    • 23/10/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/10/1990
    Entregue em 02/11/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to be come due from each obligen to the chagee on any account whatsoever to the agent and the banks or any of them (as defined in the charge) under the terms of the financing documents to which such obliger is a party and of each olbiger to the subordinated lenders agent and to the subordinated lenders under the subordinated facilities agreement (all as defined in the charge).
    Breve descrição
    Various properties registered and unregistered, f'hold and r' hold. Please see form 395 (ref: M27) for full details.
    Pessoas com direito
    • S G Warburg & Co LTD(As Security Agent)
    • G E Capital Corporate Finance Group Limited(As Subordinated Lenders Agent)
    Transações
    • 02/11/1990Registro de uma garantia
    • 18/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 13/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 25/10/1989
    Entregue em 31/10/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent & trustee for itself and for the banks as defined in the charge & to G.e capital corporate furnace group limited as agent & trustee for the subordinated lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the financing docs as defined in the charge & the subordinated facilities agreement dated 17.4.89
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • S.G. Warburg & Co Limited
    Transações
    • 31/10/1989Registro de uma garantia
    • 01/11/1990Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 31/03/1994Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 13/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security registered in scotland
    Criado em 07/08/1986
    Entregue em 21/08/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Charge over all the properties listed in the schedule attached to the form 395.
    Pessoas com direito
    • Balfour Beatty Limited
    Transações
    • 21/08/1986Registro de uma garantia
    Mortgage
    Criado em 24/11/1939
    Entregue em 15/12/1939
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc
    Breve descrição
    The camsden town bakery. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • National Prov Bank LTD
    Transações
    • 15/12/1939Registro de uma garantia
    • 14/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 24/11/1939
    Entregue em 15/12/1939
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys etc
    Breve descrição
    29, kensington high st, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • National Provincial Bank LTD
    Transações
    • 15/12/1939Registro de uma garantia
    Mortgage
    Criado em 24/11/1939
    Entregue em 15/12/1939
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc
    Breve descrição
    47, high st, floating, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • National Provincial Bank LTD
    Transações
    • 15/12/1939Registro de uma garantia
    • 14/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 24/11/1939
    Entregue em 15/12/1939
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc
    Breve descrição
    23, golden green rd, 1, accomodation rd, london, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • National Provincial Bank LTD
    Transações
    • 15/12/1939Registro de uma garantia
    • 14/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 24/11/1939
    Entregue em 15/12/1939
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc
    Breve descrição
    11, princes parade, north finchley, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • National Provincial Bank LTD
    Transações
    • 15/12/1939Registro de uma garantia
    • 14/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0