MATTHEW BROWN LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMATTHEW BROWN LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00009446
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MATTHEW BROWN LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MATTHEW BROWN LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de MATTHEW BROWN LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para MATTHEW BROWN LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para MATTHEW BROWN LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado do capital em 08/12/2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 9

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 4

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Nomeação de Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg como diretor em 06/10/2014

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Malcolm Dunn como diretor em 06/10/2014

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr David Michael Forde como diretor em 06/10/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Anne Louise Oliver como diretor em 06/10/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Sean Michael Paterson como diretor em 08/10/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Anne Louise Oliver como secretário em 06/10/2014

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 13/09/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas preparadas até 31/12/2013

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 13/09/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Quem são os diretores de MATTHEW BROWN LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritishReporting And Accounting Manager191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrishManaging Director178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritishHead Of Uk Tax167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutchFinance Director167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Secretário
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    BritishHead Of Uk Tax132259650001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secretário
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    LAWSON, John Rochester
    12 The Farthings
    Astley Village
    PR7 1TP Chorley
    Lancashire
    Secretário
    12 The Farthings
    Astley Village
    PR7 1TP Chorley
    Lancashire
    British46210670001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Secretário
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Secretário
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870003
    ALEXANDER, Robert James William
    19 Endsleigh Gardens
    Edwalton
    NG12 4BQ Nottingham
    Diretor
    19 Endsleigh Gardens
    Edwalton
    NG12 4BQ Nottingham
    BritishCompany Director37939880002
    ALEXANDER, Robert James William
    42 Lancaster Road
    Garstang
    PR3 1JA Preston
    Lancs
    Diretor
    42 Lancaster Road
    Garstang
    PR3 1JA Preston
    Lancs
    BritishManaging Director37939880001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Diretor
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritishHead Of Uk Tax132259650001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    BritishChartered Surveyor67937290001
    DICK, Alan
    Burnbank Smithy
    Blackhall Farm
    EH54 9AN Livingston
    Diretor
    Burnbank Smithy
    Blackhall Farm
    EH54 9AN Livingston
    BritishDirector Group Financial Servi95761580002
    DICKSON, Guy Grattan
    Black Barony Home Farm
    Eddleston
    EH45 8QW Peebles
    Peeblesshire
    Diretor
    Black Barony Home Farm
    Eddleston
    EH45 8QW Peebles
    Peeblesshire
    BritishDirector19236380001
    DICKSON, James William
    23 Millbrook Close
    Wheeltonle Woods
    PR6 8JY Chorley
    Lancashire
    Diretor
    23 Millbrook Close
    Wheeltonle Woods
    PR6 8JY Chorley
    Lancashire
    BritishOperations Director30654210002
    DUNSMORE, John Michael
    29 Comiston Road
    Morningside
    EH10 6AB Edinburgh
    Diretor
    29 Comiston Road
    Morningside
    EH10 6AB Edinburgh
    BritishDirector34568410003
    HEPBURN, James
    2 The Conifers Japps Lane
    Barton
    PR3 5BG Preston
    Lancashire
    Diretor
    2 The Conifers Japps Lane
    Barton
    PR3 5BG Preston
    Lancashire
    BritishFinance Director44746620001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishChartered Secretary895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Diretor
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritishCompany Director895970001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Diretor
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritishDirector Of New Business Devel895970001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Diretor
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritishDirector895970001
    JOHNSON, David Malcolm
    Meade House 4 White Hills Croft
    Croft
    BD23 1LW Skipton
    North Yorkshire
    Diretor
    Meade House 4 White Hills Croft
    Croft
    BD23 1LW Skipton
    North Yorkshire
    BritishSales Director62994280001
    LAMBERT, Martin
    16 Beech Drive
    South Milford
    LS25 5NN Leeds
    North Yorkshire
    Diretor
    16 Beech Drive
    South Milford
    LS25 5NN Leeds
    North Yorkshire
    BritishCommercial Director54395560001
    LAURIE, John
    50 Craigleith Crescent
    EH4 3LB Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    50 Craigleith Crescent
    EH4 3LB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishMidlothian629270002
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Diretor
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant162758370001
    MACDONALD, George Brian
    23 Lindeth Road
    Silverdale
    LA5 0TT Carnforth
    Lancashire
    Diretor
    23 Lindeth Road
    Silverdale
    LA5 0TT Carnforth
    Lancashire
    BritishFinance Director46160260002
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Secretary63895470001
    MYLES, Grant
    4 Beverley Close
    Wrea Green
    PR4 2NP Preston
    Lancashire
    Diretor
    4 Beverley Close
    Wrea Green
    PR4 2NP Preston
    Lancashire
    BritishOperations Director30654230001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritishUk Tax Manager132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Diretor
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant141021760002
    PAYNE, William John
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    Diretor
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    ScotlandBritishSolicitor136005370001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Diretor
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishSolicitor46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Diretor
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishSolicitor46305030001
    SARGINSON, John
    2 Wharfe Bank
    Collingham
    LS22 5JP Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    2 Wharfe Bank
    Collingham
    LS22 5JP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishManaging Director630200001

    MATTHEW BROWN LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Letter of offset
    Criado em 14/01/1994
    Entregue em 04/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The balances at credit of any accounts held by governor and company of the bank of scotland in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental to a trust deed dated 31.3.1897
    Criado em 17/07/1912
    Entregue em 31/07/1912
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    Messuage or dwelling house and shops nos 4 & 6 pask hill street, blackpool with land forming the site thereof.
    Pessoas com direito
    • Sir Frank Hollins
    • John Leigh
    • Charles Eastwood
    Transações
    • 31/07/1912Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental to a trust deed dated 31.3.1897
    Criado em 03/01/1912
    Entregue em 20/01/1912
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing the sum of £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    The black bull inn loughton lancs with the garden and croft containing about 1 acre 1 rood 26 perches.
    Pessoas com direito
    • Henry Allison
    • Sir Frank Hollins
    • Richard Finch
    Transações
    • 20/01/1912Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental to a trust deed dated 31/3/1897 registered pursuant to an order of court dated 9.2.1912
    Criado em 11/12/1911
    Entregue em 20/02/1912
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    8 dwelling houses 10,11,12,13,14 jays row and nos 6,7,8 percy street,preston lancs subject to a yearly rent of £11.
    Pessoas com direito
    • Henry Alison
    • Richard Finch
    • Frank Hollins
    Transações
    • 20/02/1912Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Executed in pursuance of a trust deed dated 31.3.1897
    Criado em 16/12/1907
    Entregue em 16/12/1907
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The sum of £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    The bay horse inn situate at the corner of town gate and union street, leyland, lancs.
    Pessoas com direito
    • Henry Allison
    • Sir Frank Hollins
    • Richard Finch
    Transações
    • 16/12/1907Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Trust deed dated 31.3.1897
    Criado em 28/11/1907
    Entregue em 28/11/1907
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing the sum of £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    A plot of land containing 538 2/3 sq yds situate at the back of station road, bamberbridge lancs.
    Pessoas com direito
    • Richard Finch
    • Henry Allison
    • Sir Frank Hollins
    Transações
    • 28/11/1907Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Conveyance supplemental to a trust deed dated 31.3.1897
    Criado em 07/11/1907
    Entregue em 07/11/1907
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing debenture stock of £160,000
    Breve descrição
    74 inkerman street preston being a shop with off beer licence and dwelling convenience.
    Pessoas com direito
    • Henry Allison
    • Frank Hollins
    • Richard Finch
    Transações
    • 07/11/1907Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Conveyance supplemental to trust deed dated 31.1.1897
    Criado em 29/10/1906
    Entregue em 29/10/1906
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing the sum of £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    Cricketers arms jibalton inn anchors weighed inn 12 brookhouse street all in preston and part of land near the lane ends hotel, great harton near blackpool.
    Pessoas com direito
    • Henry Allison
    • Frank Hollins
    • Richard Finch
    Transações
    • 29/10/1906Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Conveyance supplemental to a trust deed dated 31ST march 1897
    Criado em 14/09/1904
    Entregue em 14/09/1904
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing the sum of £160,000 debenture stock
    Breve descrição
    Two adjoining plots of land situate in oxford street preston lancs containing 226 6/9 and 390 sq yds with public house called "fazackerly arms" and the cottage,coachouse, stable and outbuildings standing. All that messuage or dwellinghouse and premises called the white horse inn situate and numbered 348 station road, lancs.
    Pessoas com direito
    • Frank Hollins
    • Henry Allison
    • Richard Finch
    Transações
    • 14/09/1904Registro de uma garantia
    • 03/12/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0