IND COOPE (LONDON) LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | IND COOPE (LONDON) LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00043104 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de IND COOPE (LONDON) LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2020 |
Quais são as últimas submissões para IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 94 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/07/2021 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado do capital em 30/03/2021
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 86 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Término da nomeação de David Forde como diretor em 31/07/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/07/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 79 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/07/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Sean Michael Paterson como diretor em 24/04/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David James Tannahill como diretor em 24/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 24/08/2018 para 31/12/2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Quem são os diretores de IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Christopher John | Diretor | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136853310001 | ||||
MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Diretor | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | England | British | Director | 112375050001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Diretor | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | Finance Director | 257892140001 | ||||
APPLEBY, Francesca | Secretário | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627860001 | |||||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Secretário | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Secretário | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488220001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Secretário | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
TYRRELL, Helen | Secretário | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161624380001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Diretor | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | Secretary | 637110001 | |||||
CONSTANTINE, Peter Anthony | Diretor | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Chartered Surveyor Estates Dir | 114160540001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DUTTON, Philip | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
FORDE, David | Diretor | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 180590780001 | ||||
JONES, Bruce Abbott | Diretor | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | Company Director | 29595900002 | |||||
KEMP, Deborah Jane | Diretor | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | Director | 79388130005 | ||||
MCDONALD, Robert James | Diretor | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
PRESTON, Neil David | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
TANNAHILL, David James | Diretor | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | Director | 237381690001 | ||||
WHITEHEAD, Gordon William George | Diretor | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | Accountant | 13507460001 | |||||
WILFORD, Nicholas James | Diretor | The Virgate Church Street Swepstone Coalville LE6 7SA Leicester Leicestershire | British | Chartered Surveyor | 33328990001 | |||||
WILKINSON, Anthony Eric | Diretor | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 4656080002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Uk Limited | 29/08/2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Punch Taverns (Rh) Limited | 06/04/2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
IND COOPE (LONDON) LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 08/10/2014 Entregue em 15/10/2014 | Totalmente satisfeita | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Third supplemental deed of charge | Criado em 03/11/2003 Entregue em 20/11/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of charge | Criado em 22/04/2002 Entregue em 08/05/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of charge | Criado em 22/04/2002 Entregue em 08/05/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of charge | Criado em 28/06/2000 Entregue em 15/07/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Breve descrição All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Security agreement | Criado em 05/10/1999 Entregue em 21/10/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Breve descrição By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental trust deed | Criado em 13/09/1989 Entregue em 18/09/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £200,000,000 93/4% debenture stock 2019 of allied-lyons PLC created under this deed and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as secured by this deed and deed supplemental thereto. | |
Breve descrição By way of collateral security a first floating charge over both present and future including any uncalled capital. Undertaking and all property and assets. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Sixteenth supplemental trust deed | Criado em 16/02/1989 Entregue em 17/02/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £150,000,000 9 3/4% debenture stock 2019 of allied-lyons PLC constituted by this deed and all other moneys intended to be secured by this deed and various deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Breve descrição Floating charge over present & future including uncalled capital. Undertaking and all property and assets. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental trust deed | Criado em 23/11/1983 Entregue em 25/11/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £75,000,000 11 3/4 % debenture stock of allied-lyons PLC | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Equitable charge without instrument | Criado em 22/06/1983 Entregue em 13/07/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £75,000,000 debenture stock of allied lyons PLC | |
Breve descrição Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 15/03/1978 Entregue em 30/03/1978 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,352,930 created under the terms of a trust deed dated 6/6/62 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 04/04/1972 Entregue em 17/04/1972 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £100,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 11/03/1968 Entregue em 25/03/1968 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £12,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 25/08/1965 Entregue em 07/09/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 16/06/1965 Entregue em 17/06/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £2,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 14/08/1964 Entregue em 18/08/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £10,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 14/08/1964 Entregue em 18/08/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £2,623,369 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 19/02/1964 Entregue em 21/02/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £10,342,599 debenture stock of allied breweries limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 18/01/1963 Entregue em 24/01/1963 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 29/08/1962 Entregue em 03/09/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Further securing £840,035 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 29/08/1962 Entregue em 03/09/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Further securing £7,854,882 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trust deed | Criado em 06/06/1962 Entregue em 07/06/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Further securing £15,347,651 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Breve descrição Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 12/11/1954 Adquirido em 31/12/1962 Entregue em 01/01/1963 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £4,800 | |
Breve descrição "The railway tavern" sydenham, london & land with all the goodwill of the business, the benefit of the licenses held in connection therewith & full right to receive all compensation payable on account of the non renewal of the said licenses. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 08/10/1949 Adquirido em 20/05/1961 Entregue em 25/05/1961 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,500 | |
Breve descrição Yatton, 4, anslow gardens wallington, surrey. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 16/10/1944 Adquirido em 05/04/1963 Entregue em 08/04/1963 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £5,500 | |
Breve descrição "The glanfield hotel", situate at east grinstead sussex & land, fixtures & fittings about the premises, the goodwill of the business, the benefit of magistrates certificate & excise license & full right to uncover all compensation payable on account of the non renewal of any of the said licenses. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0