JOHN BARRAS & CO LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | JOHN BARRAS & CO LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00068144 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de JOHN BARRAS & CO LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CLEVELAND PLACE NOMINEE COMPANY (NO.4) LIMITED | 22/10/1993 | 22/10/1993 |
| GRAND METROPOLITAN NOMINEE COMPANY (NO.7) LIMITED | 28/05/1991 | 28/05/1991 |
| WATNEY COMBE REID (ALTON) LIMITED | 08/12/1900 | 08/12/1900 |
Quais são as últimas contas de JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 22/08/2015 |
Quais são as últimas submissões para JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaração de bens vacantes | 1 páginas | BONA | ||||||||||
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 11/01/2018 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL para Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU em 12/09/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom para Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL em 10/02/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de solvência | 9 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nomeação de Lindsay Anne Keswick como secretário em 25/04/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Claire Susan Stewart como secretário em 25/04/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ para Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT em 07/03/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2016 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 22/08/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Jonathan Robert Langford como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Daryl Antony Kelly como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Lucy Jane Bell como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 21/12/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Henry Jones como secretário em 04/12/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual encurtado de 24/08/2016 para 30/04/2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Término da nomeação de Patrick James Gallagher como diretor em 23/06/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 23/08/2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secretário | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523690001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Secretário | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secretário | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretário | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretário | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592220001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secretário | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445970001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretário | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretário | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022010001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretário | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Diretor | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Diretor | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Diretor | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Diretor | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Diretor | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Diretor | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Diretor | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Diretor | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Diretor | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Diretor | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Diretor | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de JOHN BARRAS & CO LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Place Holdings Limited | 06/04/2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
JOHN BARRAS & CO LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Criado em 15/12/2003 Entregue em 31/12/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Criado em 30/09/1985 Entregue em 07/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1288988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of £349595 5% redeemable debenture stock 2000, £24 3200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & £696193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all other monies intended to be secured by a trust deed dated 4/2/62 & deeds supplemental thereto | |
Breve descrição First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 24/05/1983 Entregue em 25/05/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney hanne truman holdings PLC and for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of a trust deed dated 7/2/62 and deeds supplemental thereto | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 28/07/1970 Entregue em 12/08/1970 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £53,127,463 including £45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| 31.7.67 trust deed | Criado em 31/07/1967 Entregue em 31/07/1967 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Trust deed securing debenture stock of watney mann LTD amouning to £45,627,463 inclusive of £35,627,463 secured by trust deed dated 7.2.62 & deeds suppl thereto. | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Equitable charge | Criado em 08/05/1967 Entregue em 26/05/1967 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £10,000,000. | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 26/07/1965 Entregue em 28/07/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £7,500,000 debenture stock of watney mann LTD. | |
Breve descrição Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 26/03/1965 Entregue em 06/04/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1.347.268 debenture stock of watney mann LTD | |
Breve descrição Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 22/01/1964 Entregue em 23/01/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing £8,000,000 debenture stock of watney mann limited. | |
Breve descrição (See doc 128 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 08/02/1962 Entregue em 08/02/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of watney mann LTD | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 07/02/1962 Entregue em 07/02/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For further securing £13,780,195 debenture stock of watney mann LTD together with a premium in respect of £7,363,992 of 10 per cent in the event of voluntary liquidation of watney mann LTD. | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
JOHN BARRAS & CO LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0