JOHN BARRAS & CO LIMITED

JOHN BARRAS & CO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJOHN BARRAS & CO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00068144
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CLEVELAND PLACE NOMINEE COMPANY (NO.4) LIMITED22/10/199322/10/1993
    GRAND METROPOLITAN NOMINEE COMPANY (NO.7) LIMITED28/05/199128/05/1991
    WATNEY COMBE REID (ALTON) LIMITED08/12/190008/12/1900

    Quais são as últimas contas de JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até22/08/2015

    Quais são as últimas submissões para JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Declaração de bens vacantes

    1 páginasBONA

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 11/01/2018

    9 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL para Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU em 12/09/2017

    2 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 07/03/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom para Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL em 10/02/2017

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 12/01/2017

    LRESSP

    Declaração de solvência

    9 páginas4.70

    Nomeação de Lindsay Anne Keswick como secretário em 25/04/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Claire Susan Stewart como secretário em 25/04/2016

    1 páginasTM02

    Endereço do domicílio registado alterado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ para Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT em 07/03/2016

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 02/03/2016 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/03/2016

    Estado do capital em 02/03/2016

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 22/08/2015

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Jonathan Robert Langford como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Daryl Antony Kelly como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Lucy Jane Bell como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 21/12/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Henry Jones como secretário em 04/12/2015

    1 páginasTM02

    Exercício contabilístico atual encurtado de 24/08/2016 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Patrick James Gallagher como diretor em 23/06/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/03/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/03/2015

    Estado do capital em 02/03/2015

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 23/08/2014

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 02/03/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/03/2014

    Estado do capital em 03/03/2014

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Quem são os diretores de JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Secretário
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523690001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    ADAMS, Susanne Margaret
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretário
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28738400002
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Secretário
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secretário
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secretário
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592220001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445970001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretário
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secretário
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022010001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secretário
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Diretor
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Diretor
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Diretor
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Diretor
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Diretor
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    MYDDELTON, Roger Hugh
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    Diretor
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    British399500001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Diretor
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Diretor
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Quem são as pessoas com controle significativo de JOHN BARRAS & CO LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06/04/2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro57987
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    JOHN BARRAS & CO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 15/12/2003
    Entregue em 31/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transações
    • 31/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Twelfth supplemental trust deed
    Criado em 30/09/1985
    Entregue em 07/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1288988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of £349595 5% redeemable debenture stock 2000, £24 3200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & £696193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all other monies intended to be secured by a trust deed dated 4/2/62 & deeds supplemental thereto
    Breve descrição
    First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transações
    • 07/10/1985Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 24/05/1983
    Entregue em 25/05/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney hanne truman holdings PLC and for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of a trust deed dated 7/2/62 and deeds supplemental thereto
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transações
    • 25/05/1983Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 28/07/1970
    Entregue em 12/08/1970
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £53,127,463 including £45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental
    Breve descrição
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transações
    • 12/08/1970Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    31.7.67 trust deed
    Criado em 31/07/1967
    Entregue em 31/07/1967
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Trust deed securing debenture stock of watney mann LTD amouning to £45,627,463 inclusive of £35,627,463 secured by trust deed dated 7.2.62 & deeds suppl thereto.
    Breve descrição
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Bros & Co LTD
    Transações
    • 31/07/1967Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Equitable charge
    Criado em 08/05/1967
    Entregue em 26/05/1967
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £10,000,000.
    Breve descrição
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Bros & Co LTD
    Transações
    • 26/05/1967Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 26/07/1965
    Entregue em 28/07/1965
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £7,500,000 debenture stock of watney mann LTD.
    Breve descrição
    Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brother LTD
    Transações
    • 28/07/1965Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 26/03/1965
    Entregue em 06/04/1965
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1.347.268 debenture stock of watney mann LTD
    Breve descrição
    Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transações
    • 06/04/1965Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 22/01/1964
    Entregue em 23/01/1964
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £8,000,000 debenture stock of watney mann limited.
    Breve descrição
    (See doc 128 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transações
    • 23/01/1964Registro de uma garantia
    Trust deed
    Criado em 08/02/1962
    Entregue em 08/02/1962
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of watney mann LTD
    Breve descrição
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brothes & Co LTD
    Transações
    • 08/02/1962Registro de uma garantia
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 07/02/1962
    Entregue em 07/02/1962
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For further securing £13,780,195 debenture stock of watney mann LTD together with a premium in respect of £7,363,992 of 10 per cent in the event of voluntary liquidation of watney mann LTD.
    Breve descrição
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transações
    • 07/02/1962Registro de uma garantia

    JOHN BARRAS & CO LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    12/01/2017Início da liquidação
    15/04/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Profissional
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Profissional
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0