FIRST ASHTON LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | FIRST ASHTON LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00087044 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de FIRST ASHTON LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica FIRST ASHTON LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Wallshaw Street Oldham OL1 3TR |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de FIRST ASHTON LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LANCASHIRE UNITED TRANSPORT LIMITED | 29/12/1905 | 29/12/1905 |
Quais são as últimas contas de FIRST ASHTON LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2020 |
Quais são as últimas submissões para FIRST ASHTON LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Silvana Nerina Glibota-Vigo como secretário em 31/07/2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 28/05/2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/05/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Silvana Nerina Glibota-Vigo como secretário em 15/11/2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Hampson como secretário em 14/11/2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 8th Floor, the Point 37 North Wharf Road London W2 1AF | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 8th Floor, the Point 37 North Wharf Road London W2 1AF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr David Brian Alexander em 30/08/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/05/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/05/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Philip Howard Medlicott como diretor em 13/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ian Humphreys como diretor em 16/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 25/03/2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Philip Howard Medlicott como diretor em 02/01/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 26/03/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de FIRST ASHTON LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER, David Brian | Diretor | Donisthorpe Street LS10 1PL Leeds Hunslet Park Depot West Yorkshire United Kingdom | England | British | 20404660006 | |||||
| HUMPHREYS, Ian | Diretor | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 Scotland | United Kingdom | British | 167157350001 | |||||
| BARRETT, Nigel John | Secretário | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | British | 15118100001 | ||||||
| BARRIE, Sidney | Secretário | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | 148441070001 | |||||||
| BEVAN, Ian | Secretário | 7 Helmsdale Close Holcombe Brook BL0 9YR Bury Lancashire | British | 36738500001 | ||||||
| BROWN, Valerie | Secretário | 20 Langcliffe Close Culcheth WA3 4LR Warrington | British | 55236540001 | ||||||
| BROWN, Valerie | Secretário | 20 Langcliffe Close Culcheth WA3 4LR Warrington | British | 55236540001 | ||||||
| GLIBOTA-VIGO, Silvana Nerina | Secretário | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 Scotland | 264607800001 | |||||||
| GRIFFITHS, Ross Gilmore | Secretário | 53 Hazelwood Road SK9 2QA Wilmslow Cheshire | British | 55789560001 | ||||||
| HAMPSON, Michael | Secretário | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | 214671140001 | |||||||
| HOUSTON, Guy Alan | Secretário | No 8 Broadstraik Gardens AB32 6JH Elrick Aberdeenshire | British | 54321810005 | ||||||
| HOUSTON, Guy Alan | Secretário | 5 Bar Croft Newbold S40 4YG Chesterfield Derbyshire | British | 54321810002 | ||||||
| LEWIS, Paul Michael | Secretário | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | 161912830001 | |||||||
| TURNER, Robert Edward | Secretário | 15 Caldwell Close Astley M29 7FN Manchester | British | 57249520002 | ||||||
| WELCH, Robert John | Secretário | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 Scotland | 188650290001 | |||||||
| WILSON, Martin Stuart | Secretário | Wallshaw Street OL1 3TR Oldham | British | 59560830002 | ||||||
| ASHMORE, John David | Diretor | Trent House Royce Way West Wittering PO20 8LN Chichester West Sussex | British | 77770870002 | ||||||
| BARRETT, Nigel John | Diretor | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 15118100001 | |||||
| BEVAN, Ian | Diretor | 7 Helmsdale Close Holcombe Brook BL0 9YR Bury Lancashire | British | 36738500001 | ||||||
| BROWN, Valerie | Diretor | 20 Langcliffe Close Culcheth WA3 4LR Warrington | British | 55236540001 | ||||||
| BROXTON, Teresa Maria | Diretor | Wallshaw Street OL1 3TR Oldham Bus Depot United Kingdom | England | British | 64374080003 | |||||
| CAMPBELL, John Andrew | Diretor | 1 Burnleys Court Methley LS26 9BP Leeds West Yorkshire | British | 60286990001 | ||||||
| CHAPMAN, Steven Paul | Diretor | 6 Conway Close Rawcliffe YO30 5WF York Yorkshire | British | 51131340003 | ||||||
| DAVIES, James Ian | Diretor | 19 Radnor Close Beighton S20 2DH Sheffield South Yorkshire | British | 31504720001 | ||||||
| DICKINSON, Rodney William | Diretor | 4 Green Meadows Marple SK6 6QF Stockport Cheshire | British | 16081370001 | ||||||
| DUNCAN, Robert Alexander | Diretor | 21 Rubislaw Den South AB15 4BD Aberdeen Scotland | British | 48510002 | ||||||
| GARD, Russell John | Diretor | 412 Kings Road OL6 9AT Ashton Under Lyne Lancashire | British | 73600520002 | ||||||
| GRIFFITHS, Ross Gilmore | Diretor | 53 Hazelwood Road SK9 2QA Wilmslow Cheshire | British | 55789560001 | ||||||
| HOUSTON, Guy Alan | Diretor | No 8 Broadstraik Gardens AB32 6JH Elrick Aberdeenshire | British | 54321810005 | ||||||
| JENKINS, Graeme Mckinlay | Diretor | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | United Kingdom | British | 153392670001 | |||||
| KAYE, David Andrew | Diretor | Donisthorpe Street LS10 1PL Leeds Hunslet Park Depot West Yorkshire | England | British | 62567010004 | |||||
| LEEDER, David John | Diretor | 3 Juniper House 140 Narrow Street E14 8BP London | England | British | 110562870001 | |||||
| LISTON, David Alexander | Diretor | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | Scotland | British | 248654370001 | |||||
| MEDLICOTT, Philip Howard | Diretor | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | United Kingdom | British | 129614380003 | |||||
| MITCHELL, Michael James Ross | Diretor | 23 Earlspark Crescent Bieldside AB15 9AY Aberdeen | British | 52062750001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de FIRST ASHTON LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Manchester Limited | 06/04/2016 | Wallshaw Street OL1 3TR Oldham Bus Depot United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
FIRST ASHTON LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 17/03/1994 Entregue em 24/03/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Letter of charge | Criado em 06/02/1991 Entregue em 18/02/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from greater manchester buses limited and/or chaterplan tours limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição All monies now or at any time hereafter standing to the credit of the account or accounts of the company in the banks books. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Letter of charge | Criado em 12/03/1987 Entregue em 20/03/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from greater manchester buses limited | |
Breve descrição All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed supplemental to a trust deed dated 27/04/1906 | Criado em 26/04/1921 Entregue em 02/05/1921 | Totalmente satisfeita | Montante garantido 300,000 debenture stock secured by the original trust deed | |
Breve descrição An indenture of mortgage for jan 1912 for £145517-7/- granted by the south lancashire tramways company to the trustees of the municipal indenture in lieu of certain freehold & leasehold land & premises situate at hindley & atherton lancs. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 15/03/1921 Entregue em 15/03/1921 | Pendente | ||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0