MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00100620
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Aurum House 2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MAPPIN & WEBB LIMITED10/12/190810/12/1908

    Quais são as últimas contas de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/01/2010

    Quais são as últimas submissões para MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 10/07/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/07/2010

    Estado do capital em 13/07/2010

    • Capital: GBP 1,264,248
    SH01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/01/2010

    3 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 01/02/2009

    11 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Richard Edwin Gerrard em 05/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Paul David Stead em 05/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Clive Sargent em 05/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony John Broderick em 05/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mrs Gillian Oliff em 05/10/2009

    1 páginasCH03

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 03/02/2008

    12 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Contas anuais preparadas até 27/01/2007

    12 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    Quem são os diretores de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OLIFF, Gillian
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Secretário
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    British128108960001
    BRODERICK, Anthony John
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Diretor
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishSales Director98431500001
    GERRARD, Richard Edwin
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Diretor
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishCommercial Director124068680001
    SARGENT, Stephen Clive
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Diretor
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishFinance Director16905350005
    STEAD, Justin Paul David
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Diretor
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandAustralianChief Executive116638810003
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretário
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretário
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishHead Of Operations61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretário
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Secretário
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    LOBB, Andrew Mark
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    Secretário
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    British74760630002
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Secretário
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Secretário
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secretário
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    BritishFinance Director62321110002
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Diretor
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishGroup Finance Dir55757700003
    ASPREY, John Rolls
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    Diretor
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    United KingdomBritishJeweller Goldsmith S68034280002
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Diretor
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritishBusiness Executive25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Diretor
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritishDirector92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Diretor
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritishDirector69874610002
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Diretor
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    BritishDirector92733900001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Diretor
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    BritishGroup Chief Executive66486140001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Diretor
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritishDirector57490310002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishGroup Retail Operations Direct61931900002
    GREEN, Edward Maurice
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    Diretor
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    BritishDirector47989150001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishCompany Director64357220001
    LOWDEN, David Soutar
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director54836190001
    MCCLOSKEY, Ciaran
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    Diretor
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    BritishDirector88312080001
    PIASECKI, Jerzy Stanislaw
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    Diretor
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    EnglandBritishDirector129561330001
    PILKINGTON, Judith Mary
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    Diretor
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    United KingdomBritishChief Executive106791670001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Diretor
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    EnglandIrishChartered Accountant950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Diretor
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director62321110002
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Diretor
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandicDirector114179720001
    SUMMERS, Jeffrey
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    Diretor
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    BritishMerchandise Director127606650001
    WEST, James Edward
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director14107350002

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of debenture
    Criado em 22/11/2005
    Entregue em 02/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landsbanki Islands Hf
    Transações
    • 02/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Criado em 05/06/2001
    Entregue em 13/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Burdale Financial Limited
    Transações
    • 13/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 13/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    Criado em 24/12/1998
    Entregue em 02/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transações
    • 02/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 26/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 24/12/1998
    Entregue em 02/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and the guarantee set out therein
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    Transações
    • 02/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 28/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 29/06/1995
    Entregue em 06/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the companies right title and interest in "the real property" as defined in form 395 together with fixed charge all of each charging companys right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security agreement) any rights or assets belonging to the company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    Transações
    • 06/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/02/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Demise supplemental to trust deed of 15 jan 1909 registered pursuant to an order of court dated 10 december 1915
    Criado em 10/11/1915
    Entregue em 15/12/1915
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    An issue of £250,000 debenture stock
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets at the time of the registration of the said debenture issue being both the present demise is in substitution of certain property in norfolk street sheffield for property no 220 regent street london present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • W.J. Mappin
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    • E.W. Grimwade
    Transações
    • 15/12/1915Registro de uma garantia
    • 12/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Land registry charge supplemental to trust deed dated 15 january 1909
    Criado em 22/10/1909
    Entregue em 26/10/1909
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £250,000 debenture stock
    Breve descrição
    Mansion house buildings queen victoria street the land comprised in land registry title no 120242 city of london. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • W.J. Mappin
    • E.W. Grimwade
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    Transações
    • 26/10/1909Registro de uma garantia
    • 12/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Instrument of charge under land transfer acts 1875 & 1897
    Criado em 15/09/1909
    Entregue em 18/09/1909
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £250,000
    Breve descrição
    158, 160 & 162 oxford street and 1 & 2 winsley street and land comprised in the title no 88368 district london parish st.marylebone.
    Pessoas com direito
    • E.W.Grimwade
    • V.Alexander
    • W.J.Mappin
    • C.H. Passingham
    Transações
    • 18/09/1909Registro de uma garantia
    • 12/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0