THOMAS COOK RETAIL LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | THOMAS COOK RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Liquidação |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00102630 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
- Atividades de agências de viagens (79110) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| GOING PLACES LEISURE TRAVEL LIMITED | 27/12/1993 | 27/12/1993 |
| PICKFORDS TRAVEL SERVICE LIMITED | 22/04/1909 | 22/04/1909 |
Quais são as últimas contas de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 30/09/2019 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2020 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2018 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Última declaração de confirmação elaborada até | 03/04/2020 |
| Próxima declaração de confirmação vence | 17/04/2020 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 03/04/2019 |
| Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Endereço do domicílio registado alterado de 10 Fleet Place London EC4M 6FZ para C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB em 01/11/2022 | 2 páginas | AD01 | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL para 10 Fleet Place London EC4M 6FZ em 31/12/2021 | 2 páginas | AD01 | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 5 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 5 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 5 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 5 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 5 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 4 páginas | NDISC | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR para Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL em 15/10/2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Westpoint Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ England para Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR em 07/10/2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Ordem do tribunal para liquidar | 7 páginas | COCOMP | ||
Quem são os diretores de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Shirley | Secretário | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | British | 65475670001 | ||||||||||
| RUSSELL, Justin Lee | Diretor | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | United Kingdom | British | 259488950001 | |||||||||
| THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Diretor | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England |
| 146474110001 | ||||||||||
| BURNS, David Campbell | Secretário | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||||||
| DETKO, Tadeusz Stephen | Secretário | Yew Tree Barn White Horse Lane Barton PR3 5AH Preston Lancashire | British | 77446300001 | ||||||||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Secretário | Hollin Grove 5 Holly Grove Dobcross OL3 5JQ Oldham Lancashire | British | 49723980004 | ||||||||||
| THORNELL, Beverley Jane | Secretário | Shorts Farm Cottage Plaistow RH14 0PJ Billingshurst West Sussex | British | 63063940002 | ||||||||||
| N F C SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | The Merton Centre 45 St Peters Street MK40 2UB Bedford Bedfordshire | 32524900003 | |||||||||||
| ARTHUR, Nigel John | Diretor | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | English | 175689210001 | |||||||||
| BARRASS, Steven Robert | Diretor | 11 The Woodlands Brockhall Village BB6 8BH Blackshaw Lancashire | British | 112159920001 | ||||||||||
| BAVISTER, John Howard | Diretor | 21 Fox Hill SE19 2UX London | England | British | 96232900001 | |||||||||
| BAYNARD, Stephen | Diretor | Bracklands House Hazel Grove GU26 6JB Hindhead Surrey | British | 35719760002 | ||||||||||
| BENNETT, Anthony John | Diretor | 13 Hale End GU22 0LH Woking Surrey | England | British | 75260940001 | |||||||||
| BLACKLEDGE, David Albert | Diretor | The Stoop Stanley SN15 3RF Chippenham Wiltshire | England | British | 123065010001 | |||||||||
| BLOODWORTH, John Milton | Diretor | 29 Thorn Road Bramhall SK7 1HG Stockport | American | 100712540002 | ||||||||||
| BURNS, David Campbell | Diretor | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||||||
| CHARNOCK, Alison | Diretor | The Stables Cross Farm Liverpool Old Road PR4 6HR Tarleton Preston | United Kingdom | British | 161617710001 | |||||||||
| CLANCY, Timothy Patrick | Diretor | 6 The Mount WA14 4DX Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 76313780002 | |||||||||
| COE, Albert Henry | Diretor | 48 Broad Walk SK9 5PL Wilmslow Cheshire | British | 3977310001 | ||||||||||
| COLLINSON, Harold Hugh | Diretor | Raaes Wyke Longlands Road LA23 1DL Windermere Cumbria | England | British | 104953440001 | |||||||||
| CONLON, James Martin | Diretor | Killonan IRISH Ballysimon County Limerick Eire | Ireland | Irish | 125103490001 | |||||||||
| CONNOLLY, Aidan Joseph | Diretor | Ridgeways 18 Chiltern Hills Road HP9 1PL Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 100376210001 | |||||||||
| CROSSLAND, David | Diretor | Daisy Hill House La Cheuve Rue JE3 9EH Grouville Jersey | Jersey | British | 3977330005 | |||||||||
| DAVIES, Roger Oliver | Diretor | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | United Kingdom | British | 13540001 | |||||||||
| DONALD, Alan Charles | Diretor | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | England | British | 252692000001 | |||||||||
| ECSERY MERRENS, Francesca Eva | Diretor | 60 Grove Park Road W4 3SD London | British | 47923900001 | ||||||||||
| ENDACOTT, Steven | Diretor | 19 Hamnet Close Banktop Astley Bridge BL1 7RZ Bolton | British | 66781360002 | ||||||||||
| EVANS, Paul Richard | Diretor | Alderne House Horsted Lane RH19 4HX Sharpthorne West Sussex | United Kingdom | British | 103115560001 | |||||||||
| FISHER, Terry | Diretor | Greylands Sharp Lane HD4 6SW Huddersfield West Yorkshire | British | 69021830001 | ||||||||||
| GADSBY, Christopher James | Diretor | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | British | 118396090002 | |||||||||
| HALLISEY, David Michael William | Diretor | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | British | 1919030001 | |||||||||
| HARRIS, David Ronald | Diretor | 2 Sheridan Place Winwick Park WA2 8XG Warrington Cheshire | British | 98073810001 | ||||||||||
| HEMINGWAY, Paul Andrew | Diretor | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | United Kingdom | British | 188221460001 | |||||||||
| JARDINE, David | Diretor | The Old Cottage Hough End SK9 7JD Alderley Edge Cheshire | British | 105046880001 | ||||||||||
| JONES, Bryn Rhys | Diretor | 39 Royal Chase TN4 8AX Tunbridge Wells Kent | British | 7382330001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cook Group Uk Limited | 06/04/2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
THOMAS COOK RETAIL LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Construction account charge | Criado em 02/04/1999 Entregue em 22/04/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The obligations of the company to the chargee to pay the developer for the fit out works and any changes in accordance with clause 8 of the prelet agreements (as defined) | |
Breve descrição All secured obligations and full credit balance thereon with all related rights/benefits therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge under land transfer acts 1875 and 1897 supplemental to a mortgage dated 6/8/24 | Criado em 20/03/1925 Entregue em 24/03/1925 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £13,444 | |
Breve descrição Land at rear of 60 and 62 long lane southwark t/n 292898. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage | Criado em 06/08/1924 Entregue em 08/08/1924 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For further securing principal sum of £13,444 secured by a debenture dated 16/5/12 | |
Breve descrição 1-9 cardol place southwark and heriditaments in long lane and tabard street southwark. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage supplemental to indenture DATED15/5/12 and further charge dated 8/4/18 | Criado em 02/11/1923 Entregue em 08/11/1923 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £146,500 | |
Breve descrição F/H property at loose road maidstone dover road folkstone st. John's road lowerstoft and sussex road brighton. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
THOMAS COOK RETAIL LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação compulsória |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0