ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00108918 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
BENHAM NEWSPAPERS LIMITED | 16/04/1910 | 16/04/1910 |
Quais são as últimas contas de ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 28/12/2014 |
Quais são as últimas submissões para ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 14/07/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Anthony Hunter em 26/11/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 28/12/2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Neil Edward Carpenter em 13/01/2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Anthony Hunter em 13/01/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Simon Alton Westrop em 13/01/2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Henry Kennedy Faure Walker em 13/01/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 31/12/2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP para Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY em 11/12/2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Paul Davidson como diretor em 11/11/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomeação de Henry Kennedy Faure Walker como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 29/12/2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2013 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/12/2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 25/12/2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Quem são os diretores de ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Secretário | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Secretário | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Diretor | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Diretor | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Financial Director | 69320190004 | ||||
GLASS, Josephine Mary | Secretário | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Secretário | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
KERR, Thomas Michael Alasdair | Secretário | Thistles Brick Kiln Lane Great Horkesley CO6 4EU Colchester Essex | British | 33161780001 | ||||||
POULTER, Peter Alvis | Secretário | 32 High Road Leavenheath CO6 4NZ Colchester Essex | British | Company Director | 2993910001 | |||||
WRIGHT, Nicolas Brian | Secretário | 20 Wavell Avenue CO2 7HR Colchester Essex | British | Finance Director & Company Sec | 14274210001 | |||||
AIKEN, Iain William | Diretor | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
BAILY, Jacqueline Anne | Diretor | 18 The Rise Fairacres Shelvers Way KT20 5QT Tadworth Surrey | British | Director | 30476580001 | |||||
BELL, Colin Murray | Diretor | 98 Lexden Road CO3 3TB Colchester Essex | British | Director | 7210800001 | |||||
BRANNIGAN, Colin Thomas | Diretor | Home Farm Barn Dakings Lane Thorpe Morieux IP30 0NX Bury St Edmunds Suffolk | British | Managing Director | 5246620001 | |||||
BROWN, James Thomson | Diretor | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Executive | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Diretor | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Company Director | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Diretor | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
ELLIS, Michael | Diretor | Stonewall Cottage High Street Layer De La Haye CO2 0DT Colchester Essex | British | Chief Executive | 56666720001 | |||||
GIBSON, Aileen Miller | Diretor | 8 Trinity Grange 319 Trinity Road SW18 London | Scottish | National Sales & Marketing Director | 71315880001 | |||||
JOSEPH, Anne Janette | Diretor | 68 Hillway N6 6DP London | England | British | Company Director | 60285460001 | ||||
KERR, Thomas Michael Alasdair | Diretor | Thistles Brick Kiln Lane Great Horkesley CO6 4EU Colchester Essex | British | Director | 33161780001 | |||||
LAURIE, Peter Mcnair | Diretor | 2 Sterling Close CO3 5DP Colchester Essex | British | Director | 14274180001 | |||||
LING, Victor George | Diretor | 5 Tusset Mews Lexden CO3 5EB Colchester Essex | British | Newspaper Sales Director | 45300090001 | |||||
MCNEIL, Martin Robert | Diretor | 59 Drury Road CO2 7UU Colchester Essex | British | Director | 43867000001 | |||||
MUNRO, Robert Kenneth | Diretor | 41a Ravensbourne Road BR1 1HW Bromley Kent | British | Company Director | 46027680001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Diretor | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
POULTER, Peter Alvis | Diretor | 32 High Road Leavenheath CO6 4NZ Colchester Essex | British | Director | 2993910001 | |||||
RADBURN, Philip Arthur | Diretor | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
ROBINSON, Eric John Mark | Diretor | 62 Brighton Road SM7 1BT Banstead Surrey | British | Director | 49621200001 | |||||
SLOWGROVE, Robert Patrick | Diretor | Jupes Hill Lodge Jupes Hill Dedham Colchester Essex | British | Director | 65486210001 | |||||
SMITH, Robert Sydneyp | Diretor | 2 Ash Grove IP9 2UW Capel St Mary Suffolk | British | Production Director | 32395820001 | |||||
THOMPSON, Paul Anthony | Diretor | 16 Coltsfoot Off Linces Way Cole Green Lane AL7 3HZ Welwyn Garden City Herts | British | Director | 14274190001 | |||||
WRIGHT, Nicolas Brian | Diretor | 20 Wavell Avenue CO2 7HR Colchester Essex | British | Finance Director & Company Sec | 14274210001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media (South) Limited | 06/04/2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
ESSEX COUNTY NEWSPAPERS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Criado em 05/12/1996 Entregue em 17/12/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee and debenture | Criado em 04/01/1996 Entregue em 19/01/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargees under the terms of each or any of the finance documents in each case together with all costs, charges and expenses incurred by any lender in connection with it's rights under the finance documents or any other documents securing such liabilities | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 29/09/1981 Entregue em 01/10/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição F/H property k/a 91 high street witham essex f/h property k/a 107 high street waldon essex f/h property k/a 38 trinity street halstead essex l/h property k/a blyths meadow braintree essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 14/05/1973 Entregue em 17/05/1973 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 10, culver street colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 24/04/1956 Entregue em 04/05/1956 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,175 | |
Breve descrição 18 cape close, colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 29/10/1955 Entregue em 09/11/1955 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,175 | |
Breve descrição House in course of erection on plot 6, cape close, colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 03/08/1955 Entregue em 08/08/1955 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,120 | |
Breve descrição 43 smythies avenue, colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 23/10/1954 Entregue em 01/11/1954 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1650 | |
Breve descrição 45, castle road colchester essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 23/07/1953 Entregue em 30/07/1953 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,300 | |
Breve descrição Dwelling house. 46, rosebery avenue colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 23/07/1953 Entregue em 30/07/1953 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,300 | |
Breve descrição Dwelling house 63, king harold road shrub end, colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 22/06/1951 Entregue em 27/06/1951 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £15,000 | |
Breve descrição 24, high street, & printing works in culver street, colchester, essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 11/01/1950 Entregue em 25/01/1950 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due etc. | |
Breve descrição Rear portion of 21 high street colchester. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 06/08/1948 Adquirido em 20/08/1949 Entregue em 02/01/1950 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1200 | |
Breve descrição No 28 maldon road colchester essex. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0