EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED

EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaEUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00122207
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    First Floor, Unit 3140 Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EUROPEAN MOTOR HOLDINGS PLC28/10/199128/10/1991
    CARGO CONTROL PLC20/10/198920/10/1989
    JANTAR PLC21/06/198921/06/1989
    JANTAR P.L.C.24/05/191224/05/1912

    Quais são as últimas contas de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2019

    Quais são as últimas submissões para EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Thomas Andrew Dale como diretor em 29/01/2020

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Elizabeth Louise Hancox como diretor em 20/09/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Thomas Andrew Dale como diretor em 04/07/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Anton Clive Jeary como diretor em 04/07/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Dr Elizabeth Louise Hancox como diretor em 01/11/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Claire Louise Catlin como diretor em 21/09/2018

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Claire Louise Catlin em 01/09/2018

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do secretário alterados para Inchcape Uk Corporate Management Limited em 01/04/2018

    3 páginasCH04

    Endereço do domicílio registado alterado de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford Oxfordshire OX5 1HT para First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN em 06/04/2018

    2 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Notificação de Inchcape International Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    6 páginasAA

    Nomeação de Mrs Claire Louise Catlin como diretor em 23/09/2016

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 22/06/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/06/2016

    Estado do capital em 23/06/2016

    • Capital: GBP 1.2
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Peter Wheatley em 29/01/2016

    3 páginasCH01

    Quem são os diretores de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United Kingdom
    Secretário
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro5200589
    100307260072
    WHEATLEY, Martin Peter
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Diretor
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Secretary55180460002
    BEACHAM, Mark Derrick
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British135313320001
    ABRAHAMS, Roger Graham
    59 Brampton Grove
    NW4 4AH London
    Diretor
    59 Brampton Grove
    NW4 4AH London
    United KingdomBritishSolicitor126200540001
    BECK, David Richard
    RG8 0JY Goring On Thames
    The Temple
    Berkshire
    Diretor
    RG8 0JY Goring On Thames
    The Temple
    Berkshire
    United KingdomBritishBusiness Consultant138403420001
    BENSON, Stuart Howard
    Hill End South Hill Avenue
    Harrow On The Hill
    HA1 3PA Harrow
    Middlesex
    Diretor
    Hill End South Hill Avenue
    Harrow On The Hill
    HA1 3PA Harrow
    Middlesex
    BritishSolicitor9292600001
    BIRCH, James Edward
    Waters Reach Mill Lane
    Little Budworth
    CW6 9DB Tarporley
    Cheshire
    Diretor
    Waters Reach Mill Lane
    Little Budworth
    CW6 9DB Tarporley
    Cheshire
    EnglishDirector25690560001
    BIZLEY, John Geoffrey
    Cinderford Hellingley
    BN27 4HL Hailsham
    East Sussex
    Diretor
    Cinderford Hellingley
    BN27 4HL Hailsham
    East Sussex
    BritishDirector35551880001
    CASEY, Joseph Laurence
    31 Kenwood Drive
    BR3 6QX Beckenham
    Kent
    Diretor
    31 Kenwood Drive
    BR3 6QX Beckenham
    Kent
    UsaManaging Director51323410001
    CATLIN, Claire Louise
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Diretor
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Director270101940001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Diretor
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director142033700001
    DALE, Thomas Andrew
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Diretor
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United KingdomBritishCompany Director260286850001
    HANCOX, Elizabeth Louise, Dr
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Diretor
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United KingdomBritishCompany Director210216760001
    JEARY, Anton Clive
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Diretor
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishAccountant169892630001
    LOCK, Spencer
    The Dower House
    Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    The Dower House
    Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director92493930001
    MCCLUSKEY, Ross
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    Oxfordshire
    Diretor
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director165677350002
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    Diretor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director108832810002
    MILLIKEN, Katherine
    Flat 4
    23 Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Diretor
    Flat 4
    23 Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    BritishSolicitor99442150001
    PALMER, Richard Terence
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    Diretor
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    EnglandBritishChief Executive16571890002
    PATON, Hamish Kinloch
    Days Orchard 28 School Road
    Penn
    HP10 8EF High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    Days Orchard 28 School Road
    Penn
    HP10 8EF High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager49687450001
    PUTNAM, Roger George, Professor
    Further Hill Grange
    Ullenhall
    B95 5PN Henley-In-Arden
    Warwickshire
    Diretor
    Further Hill Grange
    Ullenhall
    B95 5PN Henley-In-Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director7516000001
    RICHMOND, Barbara Mary
    Apartmant 1003
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    Diretor
    Apartmant 1003
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    United KingdomBritishCompany Director152559820001
    RONCHETTI, Marc Arthur
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    Diretor
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant123180830001
    SMITH, Roger John
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    Diretor
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector Of Companies14247350001
    WILSON, Ann Chrisette
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director14811650002

    Quem são as pessoas com controle significativo de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Inchcape International Holdings Limited
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    06/04/2016
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroUnited Kingdom (England) Companies House
    Número de registro3580629
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Agreement
    Criado em 28/09/1992
    Entregue em 07/10/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £195,389.22 under the terms of the agreement
    Breve descrição
    All rights title interest in and to all sums payable under the insurances.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 07/10/1992Registro de uma garantia (395)
    • 21/09/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/11/1991
    Entregue em 18/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Svenska Handelsbanken
    Transações
    • 18/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 13/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Credit agreement
    Criado em 05/12/1990
    Entregue em 17/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £38688.20 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descrição
    All rights title and in and to all sums payable under the insurance see form 395 (ref 162) for details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 17/12/1990Registro de uma garantia
    • 08/12/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 28/03/1990
    Entregue em 02/04/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & buildings on the east side of groat road, aycliffe industrial estate newton aycliffe county durham.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/04/1990Registro de uma garantia
    • 08/12/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge
    Criado em 19/02/1990
    Entregue em 01/03/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All monies now or hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 01/03/1990Registro de uma garantia
    • 08/12/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 09/01/1990
    Entregue em 11/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge, the debt represented by all sums which are or shall hereafter be standing to the credit of the deposit account numbered 37295001 held with the bank.
    Pessoas com direito
    • Sevenska Handelsbanken London Branch
    Transações
    • 11/01/1990Registro de uma garantia
    • 13/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 20/10/1989
    Entregue em 27/10/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/10/1989Registro de uma garantia
    • 27/06/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0