EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00122207 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park Birmingham |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
EUROPEAN MOTOR HOLDINGS PLC | 28/10/1991 | 28/10/1991 |
CARGO CONTROL PLC | 20/10/1989 | 20/10/1989 |
JANTAR PLC | 21/06/1989 | 21/06/1989 |
JANTAR P.L.C. | 24/05/1912 | 24/05/1912 |
Quais são as últimas contas de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2019 |
Quais são as últimas submissões para EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Thomas Andrew Dale como diretor em 29/01/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Elizabeth Louise Hancox como diretor em 20/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Thomas Andrew Dale como diretor em 04/07/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Anton Clive Jeary como diretor em 04/07/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Dr Elizabeth Louise Hancox como diretor em 01/11/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Claire Louise Catlin como diretor em 21/09/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Claire Louise Catlin em 01/09/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Inchcape Uk Corporate Management Limited em 01/04/2018 | 3 páginas | CH04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford Oxfordshire OX5 1HT para First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN em 06/04/2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notificação de Inchcape International Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mrs Claire Louise Catlin como diretor em 23/09/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 22/06/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Peter Wheatley em 29/01/2016 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Quem são os diretores de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Secretário | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham United Kingdom |
| 100307260072 | ||||||||||
WHEATLEY, Martin Peter | Diretor | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Company Secretary | 55180460002 | ||||||||
BEACHAM, Mark Derrick | Secretário | Austwick Lane Emerson Valley MK4 2DR Milton Keynes 11 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||||||
ABRAHAMS, Roger Graham | Diretor | 59 Brampton Grove NW4 4AH London | United Kingdom | British | Solicitor | 126200540001 | ||||||||
BECK, David Richard | Diretor | RG8 0JY Goring On Thames The Temple Berkshire | United Kingdom | British | Business Consultant | 138403420001 | ||||||||
BENSON, Stuart Howard | Diretor | Hill End South Hill Avenue Harrow On The Hill HA1 3PA Harrow Middlesex | British | Solicitor | 9292600001 | |||||||||
BIRCH, James Edward | Diretor | Waters Reach Mill Lane Little Budworth CW6 9DB Tarporley Cheshire | English | Director | 25690560001 | |||||||||
BIZLEY, John Geoffrey | Diretor | Cinderford Hellingley BN27 4HL Hailsham East Sussex | British | Director | 35551880001 | |||||||||
CASEY, Joseph Laurence | Diretor | 31 Kenwood Drive BR3 6QX Beckenham Kent | Usa | Managing Director | 51323410001 | |||||||||
CATLIN, Claire Louise | Diretor | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Company Director | 270101940001 | ||||||||
COWIE, Thomas, Sir | Diretor | Broadwood Hall DH7 0TD Lanchester County Durham | United Kingdom | British | Company Director | 142033700001 | ||||||||
DALE, Thomas Andrew | Diretor | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | Company Director | 260286850001 | ||||||||
HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Diretor | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | Company Director | 210216760001 | ||||||||
JEARY, Anton Clive | Diretor | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Accountant | 169892630001 | ||||||||
LOCK, Spencer | Diretor | The Dower House Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | England | British | Company Director | 92493930001 | ||||||||
MCCLUSKEY, Ross | Diretor | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 165677350002 | ||||||||
MCCORMACK, Connor | Diretor | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 108832810002 | ||||||||
MILLIKEN, Katherine | Diretor | Flat 4 23 Sunderland Terrace W2 5PA London | British | Solicitor | 99442150001 | |||||||||
PALMER, Richard Terence | Diretor | Littlethorpe Cleeve Road RG8 9BJ Goring | England | British | Chief Executive | 16571890002 | ||||||||
PATON, Hamish Kinloch | Diretor | Days Orchard 28 School Road Penn HP10 8EF High Wycombe Buckinghamshire | British | General Manager | 49687450001 | |||||||||
PUTNAM, Roger George, Professor | Diretor | Further Hill Grange Ullenhall B95 5PN Henley-In-Arden Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 7516000001 | ||||||||
RICHMOND, Barbara Mary | Diretor | Apartmant 1003 8 Dean Ryle Street SW1P 4DA London | United Kingdom | British | Company Director | 152559820001 | ||||||||
RONCHETTI, Marc Arthur | Diretor | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | Accountant | 123180830001 | ||||||||
SMITH, Roger John | Diretor | Gilvers AL3 8AD Markyate Hertfordshire | England | British | Director Of Companies | 14247350001 | ||||||||
WILSON, Ann Chrisette | Diretor | The Kingswood Ridgemount Road SL5 9RW Sunningdale Berkshire | England | British | Finance Director | 14811650002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inchcape International Holdings Limited | 06/04/2016 | St James's Square SW1Y 5LP London 22a England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Agreement | Criado em 28/09/1992 Entregue em 07/10/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £195,389.22 under the terms of the agreement | |
Breve descrição All rights title interest in and to all sums payable under the insurances. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 04/11/1991 Entregue em 18/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91 | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Credit agreement | Criado em 05/12/1990 Entregue em 17/12/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £38688.20 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Breve descrição All rights title and in and to all sums payable under the insurance see form 395 (ref 162) for details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 28/03/1990 Entregue em 02/04/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land & buildings on the east side of groat road, aycliffe industrial estate newton aycliffe county durham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Letter of charge | Criado em 19/02/1990 Entregue em 01/03/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All monies now or hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 09/01/1990 Entregue em 11/01/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of first fixed charge, the debt represented by all sums which are or shall hereafter be standing to the credit of the deposit account numbered 37295001 held with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture | Criado em 20/10/1989 Entregue em 27/10/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0