LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00142234 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
- Comércio a retalho por correspondência ou via Internet (47910) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Onde fica LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 2 Holdsworth Street BD1 4AH Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LRUK (HOLDINGS) LIMITED | 06/08/2015 | 06/08/2015 |
| REDCATS 2013 LIMITED | 18/04/2013 | 18/04/2013 |
| VERT BAUDET (UK) LIMITED | 07/08/1996 | 07/08/1996 |
| EMPIRE DIRECT LIMITED | 05/02/1990 | 05/02/1990 |
| BRADFORD TEXTILE COMPANY LIMITED(THE) | 25/11/1915 | 25/11/1915 |
Quais são as últimas contas de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2022 |
Quais são as últimas submissões para LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Término da nomeação de Michael Paul Truluck como diretor em 06/07/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Michael Truluck em 14/09/2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Notificação de Ginette Moulin como pessoa com controlo significativo em 10/04/2018 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessação de Eric Yvon Courteille como pessoa com controlo significativo em 10/04/2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessação de Nathalie Catherine Balla como pessoa com controlo significativo em 10/04/2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 11 páginas | AA | ||
Alteração dos detalhes de Lruk (Holdings) Limited como pessoa com controlo significativo em 07/11/2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Notificação de Nathalie Catherine Balla como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notificação de Eric Yvon Courteille como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 22/10/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 10 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKE, Richard | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 197432680001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Ellen | Secretário | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | 125588610001 | ||||||
| OAKES, Frederick William, Mr. | Secretário | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
| ATKINSON, Neil Gareth | Diretor | The Old Chapel Knaresborough Road Follifoot HG3 1DT Harrogate North Yorkshire | British | 72405410002 | ||||||
| BALLA, Nathalie Catherine | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 179486450001 | |||||
| BAZIN, Pascal | Diretor | 43 Bis, Avenue De La Marne Tourcoing 59200 France | French | 79523170001 | ||||||
| BOTT, Richard | Diretor | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | 49293190001 | ||||||
| CAMPBELL, William James | Diretor | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | 2303760001 | ||||||
| CHESHIRE, Mark | Diretor | Crossroads Farm Barton Le Willows YO60 7PD York North Yorkshire | United Kingdom | British | 149554830001 | |||||
| DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 164987810001 | |||||
| FAINTRENY, Eric Robert | Diretor | 40 Woodvale Crescent BD16 4AL Bingley West Yorkshire | French | 46646970001 | ||||||
| GREEN, Marianne Mckenzie | Diretor | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | 118854820001 | ||||||
| HARRIS, Michael John Charles | Diretor | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | 2307700001 | ||||||
| HAWKER, Michael Leslie | Diretor | Monkshorn East Boldre SO42 7WT Brockenhurst Hampshire | United Kingdom | British | 114261580001 | |||||
| HEAVISIDES, Henry John | Diretor | High Clere Villas 20 Margerison Road Ben Rhydding LS29 8QU Ilkley West Yorkshire | British | 57422610004 | ||||||
| HILL, Andrew Ratcliffe | Diretor | 43 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69640030001 | |||||
| IZARD, Olivier Jacques Georges | Diretor | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | 87658610002 | ||||||
| JONES, Robert Glyn | Diretor | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | 116871110002 | ||||||
| JONVILLE, Jean-Luc | Diretor | 594 Bois D'Achelles Bondues 59910 France | French | 65053520001 | ||||||
| MADELEY, Jane Elisabeth | Diretor | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | 105516350002 | |||||
| MCAULAY, Janet | Diretor | Pavilion House Coldbath Road HG2 0PB Harrogate North Yorkshire | British | 87365970001 | ||||||
| OHLSSON, Hans | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 133656790001 | |||||
| PALICH, Peter | Diretor | 33 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | British | 58037440001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew William | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 68177770002 | |||||
| ROCHE, Stephane Marie Marcel | Diretor | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | 116192560002 | ||||||
| SKELSEY, Alistair James | Diretor | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | 74013420001 | ||||||
| SMITH, Peter James | Diretor | Melville Margaret Avenue Bardsey LS17 9AT Leeds West Yorkshire | England | British | 17125140001 | |||||
| THOMSON, Alan | Diretor | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | 122421940001 | |||||
| TRULUCK, Michael Paul | Diretor | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 153010590002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Ginette Moulin | 10/04/2018 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Não | ||||||||||
Nacionalidade: French País de residência: France | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Monsieur Eric Yvon Courteille | 06/04/2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: French País de residência: France | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Madame Nathalie Catherine Balla | 06/04/2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: French País de residência: Belgium | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Lruk (Holdings) Limited | 06/04/2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Northern ireland deed of charge and assignment | Criado em 28/10/2003 Entregue em 12/11/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge and assignment | Criado em 28/10/2003 Entregue em 12/11/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 27/11/1990 Entregue em 11/12/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement and or facility letter both dated 27/11/90 | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A fourth supplemental trust deed | Criado em 27/11/1990 Entregue em 06/12/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985 90, 8 3/4 per cent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 per cent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed. | |
Breve descrição See doc M93 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Second supplemental trust deed | Criado em 06/06/1972 Entregue em 06/06/1972 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £4,202,615 outstanding under and secured by a trust deed dated 5TH may 1965 and deeds supplemental thereto | |
Breve descrição Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Supplemental trust deed for securing debenture stock | Criado em 29/01/1969 Entregue em 05/02/1969 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £2,250,000 including £1,000,000 secured by a trust deed dated 5TH may 1965 | |
Breve descrição Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 05/05/1965 Entregue em 14/05/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD | |
Breve descrição Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Equitable charge without instrument | Criado em 31/03/1965 Entregue em 14/04/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD. | |
Breve descrição Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0