H HEATON LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaH HEATON LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00143011
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de H HEATON LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica H HEATON LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de H HEATON LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HATTERSLEY HEATON LIMITED20/01/198920/01/1989
    F.H.T. OVERSEAS LIMITED14/03/198614/03/1986
    O.D.GUEST LIMITED14/02/191614/02/1916

    Quais são as últimas contas de H HEATON LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até03/01/2015

    Quais são as últimas submissões para H HEATON LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/11/2017

    10 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/11/2016

    8 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU para Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY em 18/12/2015

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 01/12/2015

    LRESSP

    Término da nomeação de Coral Suzanne Bidel como diretor em 22/10/2015

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 03/01/2015

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 23/09/2015

    • Capital: GBP 125,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Nomeação de Mr Maurice Kalsbeek como diretor em 01/07/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Daniel Marc Richard Jaffe como diretor em 30/06/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Thomas C. Reeve como diretor em 04/02/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/11/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/11/2014

    Estado do capital em 18/11/2014

    • Capital: GBP 12,500,000
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Thomas C. Reeve em 01/01/2013

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Nicolas Paul Wilkinson em 01/01/2013

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como diretor em 30/09/2014

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Miss Coral Bidel em 05/09/2014

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como diretor em 13/08/2014

    2 páginasAP01

    Nomeação de Intertrust (Uk) Limited como secretário em 13/08/2014

    2 páginasAP04

    Quem são os diretores de H HEATON LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Secretário
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro06307550
    188126550001
    KALSBEEK, Maurice Alexander
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    NetherlandsDutch198232870001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House 319
    Diretor
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House 319
    EnglandBritish48808690001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secretário
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157102390001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secretário
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833050001
    BAKER, Peter Robert
    Dumble Cottage Brookside
    Water Lane Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    Diretor
    Dumble Cottage Brookside
    Water Lane Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    British48243830002
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BOSS, Terence Steven James
    19 Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    19 Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154590001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CLARKSON, Antoni Raymond
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    Diretor
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    British95628860001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Diretor
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    DYKES, Alan
    East Down Mill
    EX31 4LZ Bugford
    Devon
    Diretor
    East Down Mill
    EX31 4LZ Bugford
    Devon
    British72428380001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Diretor
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Diretor
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Diretor
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    HUMPRIES, Michael Rodney
    29 Manor Close
    Edwalton
    NG12 4BH Nottingham
    Notts
    Diretor
    29 Manor Close
    Edwalton
    NG12 4BH Nottingham
    Notts
    British33154600001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    JONES, Ronald Cadrex
    16 Martindale
    Swallow Street
    SL0 0HX Iver
    Buckinghamshire
    Diretor
    16 Martindale
    Swallow Street
    SL0 0HX Iver
    Buckinghamshire
    British53709390001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Diretor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    O REILLY, Peter
    Mandalay Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LZ North Ferriby
    North Humberside
    Diretor
    Mandalay Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LZ North Ferriby
    North Humberside
    British39066360002
    PATON, Brian
    34 Bremeridge Road
    BA13 3UJ Westbury
    Wiltshire
    Diretor
    34 Bremeridge Road
    BA13 3UJ Westbury
    Wiltshire
    British33154610001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    READING, Anthony John
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Diretor
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17110410001
    REEVE, Thomas C.
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United StatesAmerican161822390001
    SEDGWICK, Robert
    Hall Farm House
    Meen Street Eakring
    NG22 0DD Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    Hall Farm House
    Meen Street Eakring
    NG22 0DD Newark
    Nottinghamshire
    British33154630001
    SMITH, Brian Frederick
    14 Troutbeck Crescent
    Bramcote
    NG9 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    14 Troutbeck Crescent
    Bramcote
    NG9 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154640001
    SOUTHALL, John Norman
    54 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    54 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154650001
    STARK, John David Sinclair
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    Diretor
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    British27350001
    SWAIN, Malcolm Terence
    19 Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4DY Farnham
    Surrey
    Diretor
    19 Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4DY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish50333990001
    WAGSTAFF, Neil Philip
    49 Turnberry Drive
    Beckfield Lane Acomb
    YO2 5QP York
    Diretor
    49 Turnberry Drive
    Beckfield Lane Acomb
    YO2 5QP York
    British51804690001
    WALKER, John James
    6 Morris Park
    Hartford
    CW8 1SB Northwich
    Cheshire
    Diretor
    6 Morris Park
    Hartford
    CW8 1SB Northwich
    Cheshire
    British58424540001
    WATTS, Nigel James
    Little Tidnock Farm Gawsworth
    SK11 9JD Macclesfield
    Cheshire
    Diretor
    Little Tidnock Farm Gawsworth
    SK11 9JD Macclesfield
    Cheshire
    British48505250001

    H HEATON LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A security agreement
    Criado em 30/09/2010
    Entregue em 15/10/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transações
    • 15/10/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 30/09/2010
    Entregue em 13/10/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transações
    • 13/10/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 07/05/1981
    Entregue em 12/05/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over . including book debts and other debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Limited
    Transações
    • 12/05/1981Registro de uma garantia
    Floating charge
    Criado em 23/03/1976
    Entregue em 26/03/1976
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank LTD
    Transações
    • 26/03/1976Registro de uma garantia
    • 20/08/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    H HEATON LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    01/12/2015Início da liquidação
    15/06/2018Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profissional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0